NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04342230 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 500 Brook Drive RG2 6UU Reading United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NTL HEALTHCARE PLAN TRUSTEES LIMITED | 18 dic 2001 | 18 dic 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 01 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
legacy | 185 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
legacy | 203 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||
legacy | 2 páginas | GUARANTEE1 | ||
Cambio de datos del director Ms Julia Louise Boyle el 08 mar 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de Vmed O2 Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 oct 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Vmed O2 Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 oct 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
legacy | 190 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||
legacy | 2 páginas | GUARANTEE1 | ||
Cambio de datos del secretario Vmed O2 Secretaries Limited el 09 jun 2023 | 1 páginas | CH04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
legacy | 139 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Vmed O2 Secretaries Limited como secretario el 01 nov 2021 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Gillian Elizabeth James como secretario el 01 nov 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Mine Ozkan Hifzi como director el 01 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 7 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMED O2 SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom |
| 79050630041 | ||||||||||
| BOYLE, Julia Louise | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | United Kingdom | British | 287980330001 | |||||||||
| HARDMAN, Mark David | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | United Kingdom | British | 201468840001 | |||||||||
| JAMES, Gillian Elizabeth | Secretario | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | British | 72139660003 | ||||||||||
| LUBASCH, Richard Joel | Secretario | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Secretario | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | British | 47785600002 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| BEATTIE, Dominic James Macpherson | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 150162200001 | |||||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Director | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||||||
| CASTELL, William Thomas | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | England | British | 248424970001 | |||||||||
| DUNN, Robert Dominic | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 179134020002 | |||||||||
| GALE, Robert Charles | Director | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | 96956740001 | |||||||||
| GREGG, John Francis | Director | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | 75381740001 | ||||||||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | England | British | 182167230001 | |||||||||
| HOLMAN, Robert John | Director | 8 Broad Leaze RG27 9PF Hook Hampshire | British | 108663500001 | ||||||||||
| HYNES, Rachael Marie | Director | 94 The Cornfields Hatch Warren RG22 4QD Basingstoke Hampshire | British | 98577140001 | ||||||||||
| KNAPP, James Barclay | Director | 54 Hodge Road Princeton New Jersey 08540 Usa | Us Citizen | 79688880001 | ||||||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Director | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Director | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||||||
| MCNEIL, Roderick Gregor | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | England | British | 267964620001 | |||||||||
| MILNER, Luke | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | England | British | 279697130001 | |||||||||
| OTTER, Lucy Catherine, Dr | Director | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | British | 113390020002 | ||||||||||
| PASCU, Severina-Pompilia | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | Switzerland | Romanian | 267797160001 | |||||||||
| RICHTER, Bret | Director | 245 East 63rd Street Apartment 20h 10021 New York New York United States | American | 86830760001 | ||||||||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Director | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||||||
| ROSS, Stuart | Director | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||||||
| SCHUBERT, Scott Elliott | Director | 9 William Street House William Street SW1X 9HH London | American | 89618040001 | ||||||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||||||
| TOWNSEND, Nicolas | Director | 63 Brookwood Road SW18 5BG Southfields London | United Kingdom | British | 120396560001 | |||||||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Director | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | United Kingdom | British | 248424940002 | |||||||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 140137570002 | |||||||||
| WOOD, Carol Yvonne | Director | Westerkirk Hill Lane, Colden Common SO21 1RZ Winchester Hampshire | British | 86338900001 | ||||||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NTL (BCM PLAN) PENSION TRUSTEES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vmed O2 Uk Holdings Limited | 12 oct 2023 | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Vmed O2 Uk Limited | 26 feb 2021 | 161 Hammersmith Road W6 8BS London Griffin House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Liberty Global Europe 2 Limited | 06 abr 2016 | 161 Hammersmith Road W6 8BS London Griffin House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0