BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED

BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04351324
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED?

    • Otras actividades de ingeniería (71129) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Chartford House
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    24 páginasLIQ14

    Cese del nombramiento de Gail Bamforth como director el 22 abr 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 sept 2021

    18 páginasLIQ03

    Modification des détails de Parsons Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 ene 2020

    2 páginasPSC05

    Cessation de A Person with Significant Control en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mar 2021

    1 páginasPSC07

    Notification de Ppce Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mar 2021

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Richard Stephen Laker como director el 21 ene 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Conor John Murphy como director el 24 ene 2021

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 22 sept 2020

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de 40 st. Pauls Square Birmingham B3 1FQ United Kingdom a New Chartford House Centurion Way Cleckheaton West Yorkshire BD19 3QB el 15 oct 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de asuntos

    11 páginasLIQ02

    Cese del nombramiento de Grant Vincent Richardson como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Beckwith como director el 29 feb 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Fourth Floor Central Square Forth Street Newcastle upon Tyne NE1 3PJ United Kingdom a 40 st. Pauls Square Birmingham B3 1FQ el 29 ene 2020

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Peter Vincent Stienlet como director el 24 sept 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 nov 2018

    14 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 2nd Floor 1 Central Street Manchester M2 5WR a Fourth Floor Central Square Forth Street Newcastle upon Tyne NE1 3PJ el 02 sept 2019

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Doug Roy Tidswell como director el 31 ago 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Richard Stephen Laker como director el 31 may 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Gail Bamforth como director el 31 may 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stuart Marshall como secretario el 24 may 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stuart Marshall como director el 24 may 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BEVERLEY, Stephen Leonard
    17 Westleigh
    Bingley
    BD16 4LX Bradford
    West Yorkshire
    Secretario
    17 Westleigh
    Bingley
    BD16 4LX Bradford
    West Yorkshire
    British80400460001
    CLIFTON, Peter David
    37 Buck Stone Avenue
    Alwoodley
    LS17 5EZ Leeds
    Yorkshire
    Secretario
    37 Buck Stone Avenue
    Alwoodley
    LS17 5EZ Leeds
    Yorkshire
    British97344600001
    DUCKWORTH, Jean Hilary
    Old Hall Lodge
    Walkden Road
    M28 2NH Worsley
    Manchester
    Secretario
    Old Hall Lodge
    Walkden Road
    M28 2NH Worsley
    Manchester
    British32839320001
    HIRST, David
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    Secretario
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    British122199230001
    MARSHALL, Stuart
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    Secretario
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    249690210001
    MORRIS, Brian William
    4 The Mews
    Worsley
    M28 2GT Manchester
    Greater Manchester
    Secretario
    4 The Mews
    Worsley
    M28 2GT Manchester
    Greater Manchester
    British80400390001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secretario designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BAMFORTH, Gail
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Director
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish259070860001
    BECKWITH, Nicholas
    St. Pauls Square
    B3 1FQ Birmingham
    40
    United Kingdom
    Director
    St. Pauls Square
    B3 1FQ Birmingham
    40
    United Kingdom
    United KingdomBritish237062620001
    BEVERLEY, Stephen Leonard
    17 Westleigh
    Bingley
    BD16 4LX Bradford
    West Yorkshire
    Director
    17 Westleigh
    Bingley
    BD16 4LX Bradford
    West Yorkshire
    British80400460001
    CLIFTON, Peter David
    37 Buck Stone Avenue
    Alwoodley
    LS17 5EZ Leeds
    Yorkshire
    Director
    37 Buck Stone Avenue
    Alwoodley
    LS17 5EZ Leeds
    Yorkshire
    British97344600001
    LAKER, Richard Stephen
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Director
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish160256950002
    MARSHALL, Stuart
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United KingdomBritish251508290001
    MORRIS, Brian William
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish80400390001
    MURPHY, Conor John
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Director
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    United KingdomIrish84827890002
    PITMAN, Alex John
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    EnglandBritish79967650001
    RICHARDSON, Grant Vincent, Dr
    St. Pauls Square
    B3 1FQ Birmingham
    40
    United Kingdom
    Director
    St. Pauls Square
    B3 1FQ Birmingham
    40
    United Kingdom
    United KingdomBritish173616430001
    RINGLAND, Andrew Nicholas
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish165628490001
    RYAN, Michael
    45 Dorchester Park
    Sandymoor
    WA7 1QA Runcorn
    Cheshire
    Director
    45 Dorchester Park
    Sandymoor
    WA7 1QA Runcorn
    Cheshire
    EnglandBritish96245790001
    STIENLET, Peter Vincent
    Forth Street
    NE1 3PJ Newcastle Upon Tyne
    Fourth Floor Central Square
    United Kingdom
    Director
    Forth Street
    NE1 3PJ Newcastle Upon Tyne
    Fourth Floor Central Square
    United Kingdom
    EnglandBritish212666900001
    THOMAS, Andrew Michael, Professor
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United Kingdom
    WalesBritish85988430003
    TIDSWELL, Doug Roy
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United KingdomBritish185001510001
    TURNER, Mark
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    Director
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    United KingdomBritish106433720002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Director designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    St. Pauls Square
    B3 1FQ Birmingham
    40
    United Kingdom
    03 mar 2021
    St. Pauls Square
    B3 1FQ Birmingham
    40
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10674990
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Central Square
    Forth Street
    NE1 3PJ Newcastle Upon Tyne
    Fourth Floor
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    05 may 2017
    Central Square
    Forth Street
    NE1 3PJ Newcastle Upon Tyne
    Fourth Floor
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06382975
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Brian William Morris
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    06 abr 2016
    Floor
    1 Central Street
    M2 5WR Manchester
    2nd
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 07 may 2019
    Entregado el 13 may 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC T/a Allied Irish Bank (GB)
    Transacciones
    • 13 may 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 30 abr 2019
    Entregado el 07 may 2019
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 07 may 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 30 ago 2017
    Entregado el 05 sept 2017
    Pendiente
    Breve descripción
    All freehold and leasehold properties (whether registered or unregistered) and all commonhold properties, at the date of the debenture or in the future (and from time to time) owned by the company, or in which the company holds an interest (including, but not limited to, any properties specified in the debenture) as well as the company’s present and future patents, trademarks, service marks, trade names, domain names, designs, copyrights, inventions, rights to sue for passing off, topographical or similar rights, confidential information and know-how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ldc (Managers) Limited (Crn: 02495714) (as Security Trustee)
    Transacciones
    • 05 sept 2017Registro de una carga (MR01)
    Debenture deed
    Creado el 04 abr 2003
    Entregado el 08 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene BEVERLEY CLIFTON MORRIS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 sept 2020Inicio de la liquidación
    07 sept 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Wood
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Profesional
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Steven George Hodgson
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Profesional
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0