SUPANAMES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSUPANAMES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04365792
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SUPANAMES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SUPANAMES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5th Floor, The Shipping Building Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SUPANAMES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SUPANETWORK LIMITED04 feb 200204 feb 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SUPANAMES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUPANAMES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Michele Lau como director el 17 nov 2023

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Nick Daddario como director el 01 oct 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Michele Lau como director el 01 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Anthony Winslow como director el 01 oct 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Ying Kit Wong como director el 01 oct 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Simon Martin Conyers como director el 09 oct 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jonathan Ying Kit Wong como director el 09 oct 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan Ying Kit Wong como director el 14 jun 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Simon Martin Conyers el 05 feb 2018

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Simon Martin Conyers como director el 07 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Leslie Shutler como director el 07 dic 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SUPANAMES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DADDARIO, Nicholas Anthony
    East Godaddy Way
    85284 Tempe
    2155
    Az
    United States
    Director
    East Godaddy Way
    85284 Tempe
    2155
    Az
    United States
    United StatesAmericanChief Accounting Officer284003400001
    LASHBROOKE, David Piers
    Cosmore Farmhouse
    Middlemarsh
    DT9 5QN Sherborne
    Dorset
    Secretario
    Cosmore Farmhouse
    Middlemarsh
    DT9 5QN Sherborne
    Dorset
    BritishCompany Director80518050001
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Secretario
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    BritishAccountant67037910004
    SHUTLER, James
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    England
    Secretario
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    England
    British155566760001
    WOTHERSPOON, Rebecca Jane
    Floor
    The Economist Building 25 St James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    Secretario
    Floor
    The Economist Building 25 St James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    New Zealander134162710001
    CRS LEGAL SERVICES LIMITED
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secretario designado corporativo
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    900023050001
    COLLINS, Alexander Fiske
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    United Kingdom
    Director
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    United Kingdom
    United KingdomItalianBanker135884520001
    CONYERS, Simon Martin
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    Director
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    EnglandBritishSolicitor241032990002
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Director
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritishDirector153016810001
    JOSEPH, Mark William
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    Director
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    EnglandBritishFinancier72405460001
    LASHBROOKE, Barnaby Alexander
    Cosmore Farmhouse
    Middlemarsh
    DT9 5QN Sherborne
    Dorset
    Director
    Cosmore Farmhouse
    Middlemarsh
    DT9 5QN Sherborne
    Dorset
    BritishCompany Director80517950001
    LASHBROOKE, David Piers
    Cosmore Farmhouse
    Middlemarsh
    DT9 5QN Sherborne
    Dorset
    Director
    Cosmore Farmhouse
    Middlemarsh
    DT9 5QN Sherborne
    Dorset
    BritishManager80518050001
    LAU, Michele
    East Godaddy Way
    85284 Tempe
    2155
    Az
    United States
    Director
    East Godaddy Way
    85284 Tempe
    2155
    Az
    United States
    United StatesAmericanChief Legal Officer287270810001
    MANSELL, Matthew Stephen
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5 Roundwood Avenue
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5 Roundwood Avenue
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone184595530001
    MOHR, Tobias
    c/o Webfusion Ltd
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Director
    c/o Webfusion Ltd
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United KingdomGermanFinance Manager133846810002
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Director
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    BritishDirector67037910004
    PULVERMUELLER, Patrick
    Welserstrasse 14
    Koln
    Host Europe Gmbh
    D-51149
    Germany
    Director
    Welserstrasse 14
    Koln
    Host Europe Gmbh
    D-51149
    Germany
    GermanyGermanManaging Director155584970001
    READ, Michael David
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Director
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector81004070007
    SHUTLER, James Leslie
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    England
    Director
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    England
    EnglandBritishNone184595930012
    TILL, David John
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    United Kingdom
    Director
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director133593570001
    VOLLRATH, Thomas
    Roundwood Avenue, Stockley
    Park, Uxbridge
    UB11 1FF Middlesex
    5
    Director
    Roundwood Avenue, Stockley
    Park, Uxbridge
    UB11 1FF Middlesex
    5
    EnglandGermanChief Executive Officer133811550002
    WINSLOW, Richard Anthony
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    England
    Director
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    England
    EnglandBritishNone190081230001
    WONG, Jonathan Ying Kit
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    Director
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    EnglandBritishDirector224964840001
    WONG, Jonathan Ying Kit
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    Director
    Old Vinyl Factory
    252 - 254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    Middlesex
    EnglandBritishDirector241049690001
    MC FORMATIONS LIMITED
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Director designado corporativo
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    900023040001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SUPANAMES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Old Vinyl Factory
    252-254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Old Vinyl Factory
    252-254 Blyth Road
    UB3 1HA Hayes
    5th Floor, The Shipping Building
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05306504
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene SUPANAMES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Pledge agreement over shares in a gmbh
    Creado el 13 oct 2009
    Entregado el 23 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from an obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All shares and ancillary rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Oakley Capital Limited as Note Security Agent and Creditor of the Parallel Debt
    Transacciones
    • 23 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 22 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security purpose expansion agreement executed out side the united kingdom over property situated there
    Creado el 09 sept 2009
    Entregado el 25 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The original share pledge agreement 1 shall continue in full force and effect subject to the amendments made by the agreement see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Pledgee)
    Transacciones
    • 25 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creado el 21 ago 2009
    Entregado el 08 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The share capital being 25,000 euro see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Accession deed to a debenture
    Creado el 02 abr 2008
    Entregado el 15 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 15 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture accession deed
    Creado el 02 abr 2008
    Entregado el 15 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any charging company or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Oakley Capital Limited (The Note Security Holder)
    Transacciones
    • 15 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 sept 2006
    Entregado el 04 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee or any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 04 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0