MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION

MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMENINGITIS RESEARCH FOUNDATION
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 04367866
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    Dirección de la sede social
    Room 703 The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta09 feb 2026
    Próxima declaración de confirmación vence23 feb 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta09 feb 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Timothy Robert Lloyd como director el 18 feb 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Mala Harris-Langdon como director el 18 feb 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Claytone Joab Musungu como director el 10 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024

    50 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Daniel Moed como director el 16 jul 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Plumb como director el 16 jul 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Daniel Moed como secretario el 16 jul 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stephen Charles Highwood como director el 02 jul 2024

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Room 715 the Programme Building 7th Floor the Pithay Bristol BS1 2NB England a Room 703 the Programme Building, 7th Floor the Pithay Bristol BS1 2NB el 17 may 2024

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Dr Priscilla Ngozi Ibekwe como director el 10 oct 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Jemima Mary Wei Jacobs como director el 10 oct 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Caroline Margaret Mackrill como director el 10 oct 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Megan Jane Challis como director el 15 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023

    50 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Cope como director el 18 jul 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Jon Manson como director el 09 may 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Doctor Ekundayo Kehinde Ajayi-Obe como director el 07 feb 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Susan Jane Grieve como director el 18 oct 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Claire Suzanne Leigh como director el 19 jul 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    50 páginasAA

    Cese del nombramiento de Margaret Maria Smart como director el 19 jul 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Brian Scott como director el 19 jul 2022

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AJAYI-OBE, Ekundayo Kehinde, Doctor
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritish,NigerianDoctor150463430001
    BORROW, Ray, Professor
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishConsultant Clinical Scientist236128550002
    CHALLIS, Megan Jane
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritish,GermanHead Of Strategic Partnerships314032970001
    HARRIS-LANGDON, Mala
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishDirector Of Finance332972330001
    IBEKWE, Priscilla Ngozi, Dr
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishDoctor80552970003
    JACOBS, Jemima Mary Wei
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishChartered Accountant314979950001
    JEFFERY, Sarah
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishHead Of Health264262730001
    LEIGH, Claire Suzanne
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishCompany Director298539400001
    LLOYD, Timothy Robert
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishIt Consultant265780990001
    MACKRILL, Caroline Margaret
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    United KingdomBritishManaging Director153719460001
    MUSUNGU, Claytone Joab
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    KenyaKenyanMarketing Consultant327172460001
    NALLEN, Micheal
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    IrelandIrishProgramme Director261492070001
    MOED, David Daniel
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Secretario
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    British6117110003
    BELL, Howard James
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    Director
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    BritishChief Executive8909130003
    COPE, Jane Elizabeth, Dr
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    Director
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    EnglandUnited KingdomResearch Director67677330001
    DAYMAN, Gloria Ann
    4 Spencers Court
    Alveston
    BS35 3BA Bristol
    South Gloucestershire
    Director
    4 Spencers Court
    Alveston
    BS35 3BA Bristol
    South Gloucestershire
    BritishHousewife83215310001
    GILBERT, Mathew
    27 - 29 Baldwin Street
    BS1 1LT Bristol
    Newminster House
    England
    Director
    27 - 29 Baldwin Street
    BS1 1LT Bristol
    Newminster House
    England
    EnglandBritishCharity Director175931070001
    GRIEVE, Susan Jane, Dr
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    Director
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    EnglandBritishPharma & Biotech Consultant149292740001
    GRIFFIN, George Edward, Professor
    8 Buxton Drive
    KT3 3UZ New Malden
    Surrey
    Director
    8 Buxton Drive
    KT3 3UZ New Malden
    Surrey
    United KingdomBritishProfessor Of Infectious Diseases97507600001
    HIGHWOOD, Stephen Charles
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    EnglandBritishBusiness Development Director140907000002
    LAMBERT, Harold Philip
    69 Christchurch Road
    SW14 7AN London
    Director
    69 Christchurch Road
    SW14 7AN London
    BritishRetired82618840001
    MACHUGH, Linda May
    72 Magherahamlet Road
    BT24 8JZ Ballynahinch
    County Down
    Director
    72 Magherahamlet Road
    BT24 8JZ Ballynahinch
    County Down
    Northern IrelandBritishCompany Director313987010001
    MANSON, Nicholas Jon, Dr
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    Director
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    EnglandBritishGeneral Manager164437700001
    MOED, David Daniel
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant6117110003
    MURPHY, Jane
    Midland Way
    Thornbury
    BS35 2BS Bristol
    Director
    Midland Way
    Thornbury
    BS35 2BS Bristol
    EnglandBritishBusinesswoman177631440001
    O'BRIEN, Margaret
    6 Handpark
    IRISH Rush
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    Director
    6 Handpark
    IRISH Rush
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishAssistant Director Of Nursing100482320001
    PACE, Beverley Helen
    3 Shepherds Green
    BR7 6PA Chislehurst
    Kent
    Director
    3 Shepherds Green
    BR7 6PA Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritishDirector33857940001
    PICK, Angela Jane
    10 Davids Lane
    Alveston
    BS35 3LW Bristol
    South Gloucestershire
    Director
    10 Davids Lane
    Alveston
    BS35 3LW Bristol
    South Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Secretary82618890001
    PICK, Francis David
    10 Davids Lane
    Alveston
    BS35 3LW Bristol
    South Glocestershire
    Director
    10 Davids Lane
    Alveston
    BS35 3LW Bristol
    South Glocestershire
    EnglandBritishGarage Proprietor82618970001
    PLUMB, Jane Elizabeth
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    Director
    The Programme Building, 7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 703
    England
    United KingdomBritishChief Executive285454420001
    SCOTT, Brian, Dr
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    Director
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    Northern IrelandBritish,IrishRetired109168100003
    SMART, Margaret Maria
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    Director
    7th Floor
    The Pithay
    BS1 2NB Bristol
    Room 715 The Programme Building
    England
    IrelandBritish,IrishDirector Retail261506200001
    STIRLING, Simon
    Coleraine Road
    Blackheath
    SE3 7PF London
    55
    Uk
    Director
    Coleraine Road
    Blackheath
    SE3 7PF London
    55
    Uk
    United KingdomBritishBarrister At Law134855550001
    TANG, Christoph, Professor
    27 - 29 Baldwin Street
    BS1 1LT Bristol
    Newminster House
    England
    Director
    27 - 29 Baldwin Street
    BS1 1LT Bristol
    Newminster House
    England
    EnglandBritishProfessor Of Microbiology185793830001
    TAYLOR, Kimberley Jane
    Crofton
    25 Udney Park Road
    TW11 9BB Teddington
    Middlesex
    Director
    Crofton
    25 Udney Park Road
    TW11 9BB Teddington
    Middlesex
    EnglandBritishEvents And Corporate Hospitali80156730001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    09 feb 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0