MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION
Visión general
Nombre de la empresa | MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
Número de empresa | 04367866 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
Dirección de la sede social | Room 703 The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 feb 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 23 feb 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 feb 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Timothy Robert Lloyd como director el 18 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Mala Harris-Langdon como director el 18 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Claytone Joab Musungu como director el 10 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 50 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de David Daniel Moed como director el 16 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Plumb como director el 16 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de David Daniel Moed como secretario el 16 jul 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Charles Highwood como director el 02 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Room 715 the Programme Building 7th Floor the Pithay Bristol BS1 2NB England a Room 703 the Programme Building, 7th Floor the Pithay Bristol BS1 2NB el 17 may 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Priscilla Ngozi Ibekwe como director el 10 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Miss Jemima Mary Wei Jacobs como director el 10 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Caroline Margaret Mackrill como director el 10 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Megan Jane Challis como director el 15 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 50 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Cope como director el 18 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Nicholas Jon Manson como director el 09 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Doctor Ekundayo Kehinde Ajayi-Obe como director el 07 feb 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Susan Jane Grieve como director el 18 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Claire Suzanne Leigh como director el 19 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 50 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Margaret Maria Smart como director el 19 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Brian Scott como director el 19 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJAYI-OBE, Ekundayo Kehinde, Doctor | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British,Nigerian | Doctor | 150463430001 | ||||
BORROW, Ray, Professor | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Consultant Clinical Scientist | 236128550002 | ||||
CHALLIS, Megan Jane | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British,German | Head Of Strategic Partnerships | 314032970001 | ||||
HARRIS-LANGDON, Mala | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Director Of Finance | 332972330001 | ||||
IBEKWE, Priscilla Ngozi, Dr | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Doctor | 80552970003 | ||||
JACOBS, Jemima Mary Wei | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Chartered Accountant | 314979950001 | ||||
JEFFERY, Sarah | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Head Of Health | 264262730001 | ||||
LEIGH, Claire Suzanne | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Company Director | 298539400001 | ||||
LLOYD, Timothy Robert | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | It Consultant | 265780990001 | ||||
MACKRILL, Caroline Margaret | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | United Kingdom | British | Managing Director | 153719460001 | ||||
MUSUNGU, Claytone Joab | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | Kenya | Kenyan | Marketing Consultant | 327172460001 | ||||
NALLEN, Micheal | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | Ireland | Irish | Programme Director | 261492070001 | ||||
MOED, David Daniel | Secretario | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | British | 6117110003 | ||||||
BELL, Howard James | Director | The Manor House Nesfield LS29 0BN Ilkley North Yorkshire | British | Chief Executive | 8909130003 | |||||
COPE, Jane Elizabeth, Dr | Director | 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 715 The Programme Building England | England | United Kingdom | Research Director | 67677330001 | ||||
DAYMAN, Gloria Ann | Director | 4 Spencers Court Alveston BS35 3BA Bristol South Gloucestershire | British | Housewife | 83215310001 | |||||
GILBERT, Mathew | Director | 27 - 29 Baldwin Street BS1 1LT Bristol Newminster House England | England | British | Charity Director | 175931070001 | ||||
GRIEVE, Susan Jane, Dr | Director | 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 715 The Programme Building England | England | British | Pharma & Biotech Consultant | 149292740001 | ||||
GRIFFIN, George Edward, Professor | Director | 8 Buxton Drive KT3 3UZ New Malden Surrey | United Kingdom | British | Professor Of Infectious Diseases | 97507600001 | ||||
HIGHWOOD, Stephen Charles | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | England | British | Business Development Director | 140907000002 | ||||
LAMBERT, Harold Philip | Director | 69 Christchurch Road SW14 7AN London | British | Retired | 82618840001 | |||||
MACHUGH, Linda May | Director | 72 Magherahamlet Road BT24 8JZ Ballynahinch County Down | Northern Ireland | British | Company Director | 313987010001 | ||||
MANSON, Nicholas Jon, Dr | Director | 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 715 The Programme Building England | England | British | General Manager | 164437700001 | ||||
MOED, David Daniel | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 6117110003 | ||||
MURPHY, Jane | Director | Midland Way Thornbury BS35 2BS Bristol | England | British | Businesswoman | 177631440001 | ||||
O'BRIEN, Margaret | Director | 6 Handpark IRISH Rush Co. Dublin Republic Of Ireland | Ireland | Irish | Assistant Director Of Nursing | 100482320001 | ||||
PACE, Beverley Helen | Director | 3 Shepherds Green BR7 6PA Chislehurst Kent | United Kingdom | British | Director | 33857940001 | ||||
PICK, Angela Jane | Director | 10 Davids Lane Alveston BS35 3LW Bristol South Gloucestershire | England | British | Company Secretary | 82618890001 | ||||
PICK, Francis David | Director | 10 Davids Lane Alveston BS35 3LW Bristol South Glocestershire | England | British | Garage Proprietor | 82618970001 | ||||
PLUMB, Jane Elizabeth | Director | The Programme Building, 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 703 England | United Kingdom | British | Chief Executive | 285454420001 | ||||
SCOTT, Brian, Dr | Director | 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 715 The Programme Building England | Northern Ireland | British,Irish | Retired | 109168100003 | ||||
SMART, Margaret Maria | Director | 7th Floor The Pithay BS1 2NB Bristol Room 715 The Programme Building England | Ireland | British,Irish | Director Retail | 261506200001 | ||||
STIRLING, Simon | Director | Coleraine Road Blackheath SE3 7PF London 55 Uk | United Kingdom | British | Barrister At Law | 134855550001 | ||||
TANG, Christoph, Professor | Director | 27 - 29 Baldwin Street BS1 1LT Bristol Newminster House England | England | British | Professor Of Microbiology | 185793830001 | ||||
TAYLOR, Kimberley Jane | Director | Crofton 25 Udney Park Road TW11 9BB Teddington Middlesex | England | British | Events And Corporate Hospitali | 80156730001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
09 feb 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0