CQ2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CQ2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04371302 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CQ2 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CQ2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5th Floor 88 Church Street L1 3HD Liverpool England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CQ2 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CENTRIX Q2 LIMITED | 11 nov 2004 | 11 nov 2004 |
| CENTRIX MARKETING & ADVERTISING LIMITED | 11 feb 2002 | 11 feb 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CQ2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ene 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CQ2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Miles Johnson-Treherne el 02 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Allan James Stuart Leech el 02 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Notification de Heritage Great Britain Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Allan James Leech en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Peter Miles Johnson-Treherne en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ene 2021 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ene 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ene 2019 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2019 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2018 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Suite 37 the Colonnades Albert Dock Liverpool Merseyside L3 4AA a 5th Floor 88 Church Street Liverpool L1 3HD el 10 may 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Trevor Bracken como director el 09 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 043713020003, creada el 03 dic 2015 | 28 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Brian Mcaleavy como director el 06 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CQ2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, Gary | Secretario | 88 Church Street L1 3HD Liverpool 5th Floor England | 168939190001 | |||||||
| JOHNSON-TREHERNE, Peter Miles | Secretario | 88 Church Street L1 3HD Liverpool 5th Floor England | British | 154019320002 | ||||||
| JOHNSON-TREHERNE, Peter Miles | Director | 88 Church Street L1 3HD Liverpool 5th Floor England | England | British | 68217190004 | |||||
| LEECH, Allan James Stuart | Director | 88 Church Street L1 3HD Liverpool 5th Floor England | England | British | 148842590001 | |||||
| CUSHION, Peter | Secretario | 286 Waterloo Quay Waterloo Road L3 0BS Liverpool Merseyside | British | 86422110001 | ||||||
| TREHERNE, Peter | Secretario | 112 School Lane Woolton L25 7UD Liverpool Merseyside | British | 68217190001 | ||||||
| WYLLIE, Victoria Claire | Secretario | Suite 37 The Colonnades Albert Dock L3 4AA Liverpool Merseyside | 154166510001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 51460000001 | |||||||
| BRACKEN, John Trevor | Director | Suite 37 The Colonnades Albert Dock L3 4AA Liverpool Merseyside | England | British | 12041590004 | |||||
| BRADSHAW, Robert Pryce | Director | The Summit 23 Dawstone Road CH60 0BT Heswall Merseyside | British | 72954640001 | ||||||
| KILLEEN, Ian Derrick | Director | 381 Orrell Road Orrell WN5 8QZ Wigan Lancashire | England | British | 60829000002 | |||||
| MCALEAVY, Philip Brian | Director | Suite 37 The Colonnades Albert Dock L3 4AA Liverpool Merseyside | England | British | 12041580003 | |||||
| WESTGATE, Dudley Charles Salmon | Director | 11 Blackthorn Close Newton With Scales PR4 3TU Preston Lancashire | England | British | 81131850001 | |||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 51459990001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 51460000001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CQ2 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Great Britain Plc | 01 nov 2021 | 5th Floor L1 3HD Liverpool 88 Church Street Merseyside United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Allan James Leech | 06 abr 2016 | 88 Church Street L1 3HD Liverpool 5th Floor England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Peter Miles Johnson-Treherne | 06 abr 2016 | 88 Church Street L1 3HD Liverpool 5th Floor England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CQ2 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 03 dic 2015 Entregado el 17 dic 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción N/A. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 13 feb 2007 Entregado el 17 feb 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 oct 2002 Entregado el 29 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0