MVI SOFTWARE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | MVI SOFTWARE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04376567 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MVI SOFTWARE LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra MVI SOFTWARE LIMITED?
Dirección de la sede social | Sanderson House Poplar Way S60 5TR Sheffield South Yorkshire United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MVI SOFTWARE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
INGLEBY (1492) LIMITED | 19 feb 2002 | 19 feb 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MVI SOFTWARE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MVI SOFTWARE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Aptean Emea Clearing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 abr 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 7 Rushmills Northampton NN4 7YB England a Sanderson House Poplar Way Sheffield South Yorkshire S60 5TR el 09 abr 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 feb 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Louise Chalmers como director el 11 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevin James Mcadams como director el 11 dic 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Nicola Marrison como director el 11 dic 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra Ann Cummings como director el 11 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Notification de Aptean Emea Clearing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 abr 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Robert Smith en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 abr 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Registro de la carga 043765670001, creada el 15 jun 2020 | 32 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 043765670002, creada el 15 jun 2020 | 32 páginas | MR01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 43 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Karen Louise Chalmers como director el 01 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Gibson Somerville como director el 01 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MVI SOFTWARE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARRISON, Nicola | Director | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 263483420001 | ||||
MCADAMS, Kevin James | Director | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | United States | American | Director | 277744300001 | ||||
STEIN, Hellen Maria | Director | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | England | British | Senior Legal Counsel | 267152760001 | ||||
COEN, Timothy Fredericks | Secretario | Davis Drive GA 30327 Atlanta 1000 Georgia Usa | American | Senior Vp & General Counsel | 133948260001 | |||||
CUMMINGS, Julian Timothy | Secretario | Pioneer House 7 Rushmills NN4 7YB Northampton Nortamptonshire | 166804920001 | |||||||
KANTELIP, Raphael | Secretario | Duke Street SL4 1SJ Windsor 57 Berkshire Uk | French | Financial Controller | 140548460001 | |||||
MASSEUR, Franciscus Leonardus Lodewijk Arthur | Secretario | Divertimentostraat 4 EC 1312 Almere Holland | Dutch | Vp Finance Emea | 117533800001 | |||||
MASSEUR, Franciscus Leonardus Lodewijk Arthur | Secretario | Divertimentostraat 4 EC 1312 Almere Holland | Dutch | Vp Finance Emea | 117533800001 | |||||
MASSEY, Steven Justin | Secretario | 25 Tower Road WR3 7AF Worcester Worcestershire | British | Chartered Accountant | 63628270002 | |||||
SUTCLIFFE, Siobhan Linda | Secretario | Apartment 103 New Hampton Lofts B18 6BG Birmingham | British | Director | 81746570002 | |||||
TAYLOR, Robert William | Secretario | 24 Pooley Green Road TW20 8AF Egham Surrey | British | Legal Counsel | 115640040001 | |||||
WIGHT, Robin Keith | Secretario | 2 Sidney Drive Kingsley Holt ST10 2BH Stoke On Trent Staffordshire | British | 65120470001 | ||||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham West Midlands | 39944230001 | |||||||
ARCHER, Robert Jonathan | Director | 446 Quinton Road West Quinton B32 1QG Birmingham | British | Director | 81746530001 | |||||
BURKETT, Vincent | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 Northamptonshire United Kingdom | Texas Usa | Usa | Principal-Private Equity Firm | 174734880001 | ||||
CAMERON, Bruce Warren | Director | Oxmoor Court IL 60175 St Charles 502 Usa | Other | Svp | 129536790001 | |||||
CHALMERS, Karen Louise, Ms. | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | United Kingdom | British | Emea Human Resources Director | 265852240001 | ||||
COEN, Timothy Fredericks | Director | Davis Drive GA 30327 Atlanta 1000 Georgia Usa | American | Senior Vp & General Counsel | 133948260001 | |||||
CUMMINGS, Julian Timothy | Director | Pioneer House 7 Rushmills NN4 7YB Northampton Nortamptonshire | England | British | Vp Finance Emea | 159136130001 | ||||
CUMMINGS, Sandra Ann | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | United Kingdom | British | Finance Director | 269384760001 | ||||
DEXTER, Stephen, Vp | Director | Pioneer House 7 Rushmills NN4 7YB Northampton Nortamptonshire | Usa | Usa | Cfo | 159380970001 | ||||
HICKEY, James | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 Northamptonshire United Kingdom | Arizona Usa | American | Principal-Private Equity Firm | 174734950001 | ||||
KANTELIP, Raphael | Director | Duke Street SL4 1SJ Windsor 57 Berkshire Uk | United Kingdom | French | Financial Controller | 140548460001 | ||||
LAVELLE, Matthew | Director | Concord Creek Trail GA 30041 Cumming 2430 Goergia | United States | American | Vp, Finance | 137900080001 | ||||
MASSEUR, Franciscus Leonardus Lodewijk Arthur | Director | Divertimentostraat 4 EC 1312 Almere Holland | Dutch | Vp Finance | 117533800001 | |||||
MASSEY, Steven Justin | Director | 25 Tower Road WR3 7AF Worcester Worcestershire | British | Chartered Accountant | 63628270002 | |||||
MUSSER, Eric Wayne | Director | Sunset Drive GA 30071 Norcross 727 Usa | Usa | United States | Ceo | 129538330001 | ||||
SAKPAL, Sureshchandra Vishwas | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | England | British | Finance Director | 127856400001 | ||||
SOMERVILLE, Alan Gibson | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | England | British | Managing Director | 78626170001 | ||||
SUTCLIFFE, Mark David | Director | Apartment 103 New Hampton Lofts B18 6BG Birmingham | British | Director | 81746280002 | |||||
SUTCLIFFE, Siobhan Linda | Director | Apartment 103 New Hampton Lofts B18 6BG Birmingham | British | Director | 81746570002 | |||||
TAYLOR, Robert William | Director | 24 Pooley Green Road TW20 8AF Egham Surrey | United Kingdom | British | Legal Counsel | 115640040001 | ||||
TEILLON, Marc | Director | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 Northamptonshire United Kingdom | New York Usa | American | Principal-Private Equity Firm | 174734780001 | ||||
WIGHT, Robin Keith | Director | 2 Sidney Drive Kingsley Holt ST10 2BH Stoke On Trent Staffordshire | British | Director | 65120470001 | |||||
INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Director corporativo | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham West Midlands | 39944220001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MVI SOFTWARE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptean Emea Clearing Limited | 23 abr 2019 | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr. Robert Smith | 06 abr 2016 | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene MVI SOFTWARE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 15 jun 2020 Entregado el 26 jun 2020 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 15 jun 2020 Entregado el 26 jun 2020 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0