ROCKFORD GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ROCKFORD GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04380883 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ROCKFORD GROUP LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ROCKFORD GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Embankment West Tower 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROCKFORD GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROCKFORD GROUP PLC | 25 feb 2002 | 25 feb 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ROCKFORD GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROCKFORD GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Ian James Donaldson como director el 31 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Janice Deakin como director el 30 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Stewart Kennedy como director el 30 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de David Robert Harding como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Annabel Felicity Wilson como secretario el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Janice Deakin como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Scott Stewart Kennedy como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Craig David Ball como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Dean Clarke como secretario el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Gilles Normand como director el 03 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||
Modification des détails de Swinton (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 jun 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director David Robert Harding el 19 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Gilles Normand el 19 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Embankment West Tower 101 Cathedral Approach Salford M3 4FB United Kingdom a Embankment West Tower 101 Cathedral Approach Salford M3 7FB el 10 jul 2017 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ROCKFORD GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Dean | Secretario | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | 255363720001 | |||||||
| BALL, Craig David | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 109298830003 | |||||
| DONALDSON, Ian James | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 253784440001 | |||||
| DAVIDSON, Leon Laurence | Secretario | 10 Saint Andrews Walk LS17 7TS Leeds Yorkshire | Irish | 80631150001 | ||||||
| DESRAY, Georges | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 169858060001 | |||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Secretario | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | English | 1778900007 | ||||||
| PLUMER, Christian Charles | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 189565180001 | |||||||
| WILSON, Annabel Felicity | Secretario | RG1 8DA Reading Norman Place United Kingdom | 196039080001 | |||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| BARDET, Christophe Marie Fred | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | French | 165770320001 | |||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||
| BROWNE, Mark Christopher Clinton | Director | 50 Greave Road Hade Edge HD9 2AQ Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | 102521800001 | |||||
| CLARE, Anthony Peter | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | United Kingdom | British | 51441260002 | |||||
| DALY, James Francis | Director | 27 High Street South Milford LS25 5AA Leeds West Yorkshire | British | 102521790001 | ||||||
| DAVIDSON, Leon Laurence | Director | 10 Saint Andrews Walk LS17 7TS Leeds Yorkshire | England | Irish | 80631150001 | |||||
| DEAKIN, Janice | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House United Kingdom | England | British | 238355920001 | |||||
| DESRAY, Georges | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | French | 167333040002 | |||||
| HALPIN, Peter Joseph | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | United Kingdom | British | 38789050002 | |||||
| HARDILL, Allan | Director | The Old Dairy Hey Farm Holt Head Road HD7 5TU Slaithwaite Yorkshire | England | British | 70902270002 | |||||
| HARDING, David Robert | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 196407900002 | |||||
| KENNEDY, Scott Stewart | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 211745270001 | |||||
| NORMAND, Gilles | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | French | 175288680002 | |||||
| PLUMER, Christian Charles | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 130813500001 | |||||
| TURNER, Allister Paul | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | British | 86414540001 | |||||
| WEATHERS, Gail Elizabeth | Director | 9 Low Fold LS19 6DE Rawden West Yorkshire | England | British | 102735780001 | |||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 | |||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 51066720001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ROCKFORD GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swinton (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | 101 Cathedral Approach M3 4FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ROCKFORD GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 17 dic 2004 Entregado el 06 ene 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £110,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 dic 2004 Entregado el 06 ene 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £110,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 abr 2003 Entregado el 23 abr 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 30 ago 2002 Entregado el 05 sept 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold property 27 st james street bacup t/n LA44775. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge of deposit | Creado el 14 mar 2002 Entregado el 19 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit initially of £50,000 credited to account designation 14078252 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 mar 2002 Entregado el 19 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0