HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED

HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04386957
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hotwork Combustion Technology Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    West Yorkshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    READCO 328 LIMITED05 mar 200205 mar 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 dic 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Sterling Bloom Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 feb 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Sterling Thermal Technology South Building Brunel Road Rabans Lane Industrial Area Aylesbury Buckinghamshire HP19 8TD England a Hotwork Combustion Technology Bretton Street Savile Town Dewsbury West Yorkshire WF12 9DB el 26 feb 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael Paver como director el 31 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Kathryn Elizabeth Tackley como secretario el 31 ene 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Paver como secretario el 31 ene 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Denis Hunzinger como director el 08 ene 2018

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Sterling Bloom Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Sterling Industries Plc Sterling House Brunel Road Aylesbury Buckinghamshire HP19 8SS a Sterling Thermal Technology South Building Brunel Road Rabans Lane Industrial Area Aylesbury Buckinghamshire HP19 8TD el 03 ago 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    25 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TACKLEY, Kathryn Elizabeth
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    242817520001
    BOYCE, David Walter
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    Director
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    United StatesAmerican190611570001
    MILLS, Robert Peter
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    Director
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish199582930001
    BLUNN, David Howard
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    Secretario
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    British171553420001
    CROWTHER, Brian
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    British81627250001
    CROWTHER, Patricia
    Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    14
    West Yorkshire
    Secretario
    Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    14
    West Yorkshire
    British151380250001
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British900012370001
    PAVER, Michael
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    Secretario
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    182924880001
    ROBINSON, Carol
    Rosedale Avenue
    WF2 6EP Wakefield
    17
    West Yorkshire
    Secretario
    Rosedale Avenue
    WF2 6EP Wakefield
    17
    West Yorkshire
    British151380300001
    ARMITAGE, Christopher Robert
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    Director
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    United KingdomBritish62637840002
    BLUNN, David Howard
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    Director
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    EnglandBritish160982330001
    BOND, Julian
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    Director
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    United KingdomBritish44995320003
    CROWTHER, Brian
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish81627250001
    HUNZINGER, Denis
    Main Street
    Little Ouseburn
    YO26 9TG York
    Barley Cottage 1 Mount Pleasant
    North Yorkshire
    Director
    Main Street
    Little Ouseburn
    YO26 9TG York
    Barley Cottage 1 Mount Pleasant
    North Yorkshire
    UkBritish151379980001
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Director designado
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British900012370001
    PAVER, Michael
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish10035580002
    ROBINSON, David
    17 Rosedale Avenue
    Sandal
    WF2 6EP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    17 Rosedale Avenue
    Sandal
    WF2 6EP Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish81627450001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bloom Engineering Holdings Limited
    15 London End
    HP9 2HN Beaconsfield
    Kings Head House
    England
    06 abr 2016
    15 London End
    HP9 2HN Beaconsfield
    Kings Head House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroUk
    Número de registro9777995
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 feb 2007
    Entregado el 08 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 06 jul 2006
    Entregado el 26 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Partnership Investment Small Loans Fund L.P.
    Transacciones
    • 26 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 14 oct 2004
    Entregado el 19 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account desination 45602387 with the bank and any deposit or account of any other currency.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over deposits
    Creado el 06 mar 2003
    Entregado el 12 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A first fixed charge over any sums deposited or to be deposited by the company in any deposit account.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 12 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    (1) the deferred consideration due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the chargeand (2) £250,000 due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dyson Hotwork Limited
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0