G2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaG2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04390861
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de G2 LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra G2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de G2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AIRTIME GROUP HOLDINGS LIMITED20 mar 200220 mar 2002
    DIGAME LIMITED08 mar 200208 mar 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de G2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para G2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    8 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 08 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 23/02/2011
    RES13

    Estado de capital el 14 mar 2011

    • Capital: GBP 1.00
    6 páginasSH19

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Smyth como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 08 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2008

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2007

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de G2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Secretario
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Director
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Director
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secretario
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secretario
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Secretario
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secretario designado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Director
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Director
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Director
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Director
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Director
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Director
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Director
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Director
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Director
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Director
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Director designado
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Director
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001

    ¿Tiene G2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Syndicated debenture
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 jul 2005
    Entregado el 15 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 15 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Creado el 02 ago 2002
    Entregado el 21 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 ago 2002
    Entregado el 13 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or airtime interactive marketing LTD to the chargee on account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0