DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED

DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDORMANT COMPANY 04401640 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04401640
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRUSTMARQUE ACQUISITIONS LIMITED04 abr 200204 abr 2002
    BROOMCO (2860) LIMITED22 mar 200222 mar 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    15 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 dic 2016

    14 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT a 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG el 05 dic 2016

    2 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 044016400008

    1 páginasMR04

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 14 dic 2015

    • Capital: GBP 6,348,851
    3 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN a Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT el 04 ene 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 14 dic 2015

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de Martin John Trainer como director el 14 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Charles Mills como secretario el 14 dic 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Dermot James Joyce como director el 14 dic 2015

    1 páginasTM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed trustmarque acquisitions LIMITED\certificate issued on 11/12/15
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name11 dic 2015

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 dic 2015

    RES15

    Cese del nombramiento de James Christopher Michael Woolley como director el 03 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Neil Martin Simpson como director el 26 may 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 22 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 abr 2015

    Estado de capital el 17 abr 2015

    • Capital: GBP 810
    SH01

    Misceláneos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Cambio de datos del director Mr Dermot James Joyce el 11 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Peter Charles Mills el 02 feb 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr James Christopher Michael Woolley el 02 feb 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Martin John Trainer el 02 feb 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Dermot James Joyce el 02 feb 2015

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FERGUSON, Paul John
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    Secretario
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    British84739280002
    GODLIMAN, Victoria
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    Secretario
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    167818480001
    METCALFE, Richard Crosby, Mr.
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    Secretario
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    British73646130001
    MILLS, Peter Charles
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Secretario
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    191202760001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BLOW, Bridget Penelope
    Flat 119 B Central
    38 Paradise Street
    B1 2AF Birmingham
    West Midlands
    Director
    Flat 119 B Central
    38 Paradise Street
    B1 2AF Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish115125670001
    COOKE, Ursula
    70 Bootham
    YO30 7DF York
    Director
    70 Bootham
    YO30 7DF York
    British115125770002
    FERGUSON, Paul John
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    Director
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    EnglandBritish84739280002
    FINLAYSON, David John Mcintosh
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    British33124430005
    GODLIMAN, Victoria
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    Director
    Triune Court
    Monks Cross Drive, Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    EnglandBritish83684440003
    HADDOW, Scott William
    Chelford Road
    WA16 8LY Knutsford
    Spinney End
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Chelford Road
    WA16 8LY Knutsford
    Spinney End
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish121651070002
    JOYCE, Dermot James
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Director
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    United KingdomIrish181301350001
    LIGERTWOOD, Mark Murray
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Midlothian
    Scotland
    Director
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomUk179214640001
    LLOYD, Colin Thomas
    Fawke Common
    Underriver
    TN15 0JX Sevenoaks
    Fawke House
    Kent
    Director
    Fawke Common
    Underriver
    TN15 0JX Sevenoaks
    Fawke House
    Kent
    EnglandBritish3616430001
    METCALFE, Richard Crosby, Mr.
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    Director
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    United KingdomBritish73646130001
    MILLER, Ross Charles
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    Director
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    EnglandBritish84739210001
    ROGERS, Christine Margaret
    The Old Granary
    Chilton Road
    HP18 0DN Chearsley
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Granary
    Chilton Road
    HP18 0DN Chearsley
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66374680002
    SIMPSON, Neil Martin
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Director
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    United KingdomBritish183192810001
    TRAINER, Martin John
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Director
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish124180840001
    WOOLLEY, James Christopher Michael
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Director
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish156851530001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ¿Tiene DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2014
    Entregado el 19 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transacciones
    • 19 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 01 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 jul 2013
    Entregado el 19 jul 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque acquisitions limited.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Senior Security Agent
    Transacciones
    • 19 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 09 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 07 jun 2013
    Entregado el 14 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Dcg Nominees Limited (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 09 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 12 ago 2006
    Entregado el 18 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge of securities
    Creado el 12 ago 2006
    Entregado el 18 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Its whole right title and benefit of the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 25 jun 2002
    Entregado el 09 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Bank Investments Limited
    Transacciones
    • 09 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 jun 2002
    Entregado el 11 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Bank Investments Limited
    Transacciones
    • 11 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 abr 2002
    Entregado el 17 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Royal Bank Investments Limited
    Transacciones
    • 17 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 dic 2015Inicio de la liquidación
    10 abr 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen John Adshead
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Profesional
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Gregory Andrew Palfrey
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    Profesional
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0