DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04401640 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRUSTMARQUE ACQUISITIONS LIMITED | 04 abr 2002 | 04 abr 2002 |
| BROOMCO (2860) LIMITED | 22 mar 2002 | 22 mar 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 15 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 dic 2016 | 14 páginas | 4.68 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT a 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG el 05 dic 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 044016400008 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 14 dic 2015
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN a Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT el 04 ene 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Martin John Trainer como director el 14 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Charles Mills como secretario el 14 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Dermot James Joyce como director el 14 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed trustmarque acquisitions LIMITED\certificate issued on 11/12/15 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de James Christopher Michael Woolley como director el 03 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Martin Simpson como director el 26 may 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Miscel áneos Section 519 | 2 páginas | MISC | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Dermot James Joyce el 11 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Peter Charles Mills el 02 feb 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr James Christopher Michael Woolley el 02 feb 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Martin John Trainer el 02 feb 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Dermot James Joyce el 02 feb 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON, Paul John | Secretario | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | British | 84739280002 | ||||||
| GODLIMAN, Victoria | Secretario | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | 167818480001 | |||||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Secretario | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | British | 73646130001 | ||||||
| MILLS, Peter Charles | Secretario | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | 191202760001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BLOW, Bridget Penelope | Director | Flat 119 B Central 38 Paradise Street B1 2AF Birmingham West Midlands | England | British | 115125670001 | |||||
| COOKE, Ursula | Director | 70 Bootham YO30 7DF York | British | 115125770002 | ||||||
| FERGUSON, Paul John | Director | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | England | British | 84739280002 | |||||
| FINLAYSON, David John Mcintosh | Director | 8 Greenfields New Barn Lane Prestbury GL52 3LG Cheltenham Gloucestershire | British | 33124430005 | ||||||
| GODLIMAN, Victoria | Director | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | England | British | 83684440003 | |||||
| HADDOW, Scott William | Director | Chelford Road WA16 8LY Knutsford Spinney End Cheshire United Kingdom | England | British | 121651070002 | |||||
| JOYCE, Dermot James | Director | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | Irish | 181301350001 | |||||
| LIGERTWOOD, Mark Murray | Director | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Scotland | United Kingdom | Uk | 179214640001 | |||||
| LLOYD, Colin Thomas | Director | Fawke Common Underriver TN15 0JX Sevenoaks Fawke House Kent | England | British | 3616430001 | |||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Director | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | United Kingdom | British | 73646130001 | |||||
| MILLER, Ross Charles | Director | Primrose Farm Hagg Lane Dunnington YO19 5PE York Yorkshire | England | British | 84739210001 | |||||
| ROGERS, Christine Margaret | Director | The Old Granary Chilton Road HP18 0DN Chearsley Buckinghamshire | United Kingdom | British | 66374680002 | |||||
| SIMPSON, Neil Martin | Director | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | British | 183192810001 | |||||
| TRAINER, Martin John | Director | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | 124180840001 | |||||
| WOOLLEY, James Christopher Michael | Director | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | 156851530001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
¿Tiene DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 17 dic 2014 Entregado el 19 dic 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 17 jul 2013 Entregado el 19 jul 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque acquisitions limited.. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 07 jun 2013 Entregado el 14 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 ago 2006 Entregado el 18 ago 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge of securities | Creado el 12 ago 2006 Entregado el 18 ago 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Its whole right title and benefit of the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 25 jun 2002 Entregado el 09 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 05 jun 2002 Entregado el 11 jun 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 05 abr 2002 Entregado el 17 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0