HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED

HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04401832
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LAING INVESTMENTS UTILITIES HOLDINGS LIMITED22 mar 200222 mar 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence17 may 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    36 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    32 páginasAA

    Modification des détails de Healthcare Support (Newcastle) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 may 2023

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Watling House 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB United Kingdom a 1 Park Row Leeds LS1 5AB el 23 may 2023

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Hannah O'gorman como director el 26 abr 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Mcdonagh como director el 26 abr 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 jul 2022

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 jul 2022

    1 páginasTM02

    Modification des détails de Healthcare Support (Newcastle) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2022

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 jul 2022

    2 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de 8 White Oak Square London Road Swanley BR8 7AG England a Watling House 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB el 11 ago 2022

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Vercity Social Infrastructure (Uk) Limited como secretario el 30 jun 2022

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Alastair James Watson el 27 jun 2020

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    32 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    32 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Hcp Social Infrastructure (Uk) Limited el 23 abr 2021

    1 páginasCH04

    Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    31 páginasAA

    Cambio de datos del director Ms Hannah O'gorman el 17 jul 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    27 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr John Stephen Gordon el 02 jul 2019

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RESOLIS LIMITED
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    C/O Resolis Limited, 11th Floor, Exchange Tower
    Scotland
    Secretario corporativo
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    C/O Resolis Limited, 11th Floor, Exchange Tower
    Scotland
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro13181806
    285489620001
    BIRLEY-SMITH, Gaynor
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    Director
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    United KingdomBritishInvestment Director126862310004
    GORDON, John Stephen
    Caledonian Exchange
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Dalmore Capital
    United Kingdom
    Director
    Caledonian Exchange
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Dalmore Capital
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector203724200001
    MCDONAGH, John
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    2nd Floor Caledonian Exchange
    United Kingdom
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    2nd Floor Caledonian Exchange
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector192240500002
    WATSON, Alastair James
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House 91-93
    England
    England
    Director
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House 91-93
    England
    England
    United KingdomBritishInvestment Director164639450002
    LEWIS, Maria
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    1
    Secretario
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    1
    British152623490001
    LIMITED, Resolis
    11th Floor
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower
    Scotland
    Secretario
    11th Floor
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower
    Scotland
    298975460001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    NAYLOR, Philip
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    1
    Secretario
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    1
    201612300001
    SHELL, Peter Geoffrey
    5 Kingsdale Road
    HP4 3BS Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    5 Kingsdale Road
    HP4 3BS Berkhamsted
    Hertfordshire
    British75961450003
    VERCITY SOCIAL INFRASTRUCTURE (UK) LIMITED
    White Oak Square, London Road
    BR8 7AG Swanley
    8
    England
    Secretario corporativo
    White Oak Square, London Road
    BR8 7AG Swanley
    8
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02658304
    137166280005
    ASTERAKI, David John
    St James Park Road
    Toddington
    LU5 6AB Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    St James Park Road
    Toddington
    LU5 6AB Dunstable
    Bedfordshire
    BritishBank Executive50983030001
    BAYBUTT, Michael
    33 Curtis Wood Park Road
    CT6 7TY Herne Bay
    Kent
    Director
    33 Curtis Wood Park Road
    CT6 7TY Herne Bay
    Kent
    United KingdomBritishOperations Manager74962840001
    BERTHOU, Nicole
    3/12-16 Billyard Avenue
    Elizabeth Bay
    Nsw 2011
    Australia
    Director
    3/12-16 Billyard Avenue
    Elizabeth Bay
    Nsw 2011
    Australia
    AustralianSolutions Executive Private Ca101327730001
    BLISS, Nicholas John
    White Oak Square
    London Road
    BR8 7AG Swanley
    8
    England
    Director
    White Oak Square
    London Road
    BR8 7AG Swanley
    8
    England
    EnglandBritishSolicitor218622920001
    BRADBURY, David Richard
    London Road
    BR8 7AG Swanley
    8 White Oak Square
    England
    Director
    London Road
    BR8 7AG Swanley
    8 White Oak Square
    England
    United KingdomBritishAsset Director109853290004
    CROWTHER, Nicholas John Edward
    c/o Innisfree Limited
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    Director
    c/o Innisfree Limited
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    United KingdomBritishDirector103617880001
    CUTTANCE, Paul Francis, Mr.
    47 Burlington Gardens
    TW9 4DG Richmond
    Surrey
    Director
    47 Burlington Gardens
    TW9 4DG Richmond
    Surrey
    AustralianExecutive Manager Of Project A101327350003
    ELDRIDGE, James, Mr.
    The New House
    Aspen Close
    KT11 3AD Cobham
    Surrey
    Director
    The New House
    Aspen Close
    KT11 3AD Cobham
    Surrey
    EnglandAustralianBanking Executive125881500001
    FREW, Leilani Mae
    6 Eglinton Road,
    Glebe
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2037
    Australia
    Director
    6 Eglinton Road,
    Glebe
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2037
    Australia
    New ZealandSolution Executive107705930001
    GRAHAM, John
    c/o Innisfree Limited
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    Director
    c/o Innisfree Limited
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    United KingdomBritishInvestment Director116875070001
    HARDY, David Michael
    8 Lansdowne Circus
    CV32 4SW Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    8 Lansdowne Circus
    CV32 4SW Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant106339430001
    HARRIS, John David
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    17th Floor 200
    United Kingdom
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    17th Floor 200
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector174333200001
    HEATH, James Christopher
    White Oak Square
    London Road
    BR8 7AG Swanley
    8
    England
    Director
    White Oak Square
    London Road
    BR8 7AG Swanley
    8
    England
    United KingdomBritishDirector122413700002
    HUDSON, Ian David
    Allington House
    150 Victoria Street
    SW1E 5LB London
    Director
    Allington House
    150 Victoria Street
    SW1E 5LB London
    United KingdomBritishChartered Accountant126636920001
    JONES, Stephen Michael
    9 Silver Crescent
    Chiswick
    W4 5SF London
    Director
    9 Silver Crescent
    Chiswick
    W4 5SF London
    United KingdomBritishChartered Accountant88268290001
    LINNEY, Joseph Mark
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    1
    Director
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    1
    ScotlandBritishChartered Quantity Surveyor63161960001
    LOWRY, Steven
    8a Broomfield Road
    TW9 3HR Kew
    Surrey
    Director
    8a Broomfield Road
    TW9 3HR Kew
    Surrey
    BritishBanker112028520001
    LUCAS, Gary Stephen
    18 Willoughby Way
    Piddington
    NN7 2EH Northamptonshire
    Director
    18 Willoughby Way
    Piddington
    NN7 2EH Northamptonshire
    EnglandBritishAssociate Director70621740001
    MARSDEN, Robert James
    Park House
    2 Dee Hills Park
    CH3 5AR Chester
    Director
    Park House
    2 Dee Hills Park
    CH3 5AR Chester
    EnglandBritishProjects Director86971250002
    MCDONAGH, John
    c/o Dalmore Capital Limited
    200 Aldersgate Street
    EC1A 2ND London
    17th Floor
    England
    Director
    c/o Dalmore Capital Limited
    200 Aldersgate Street
    EC1A 2ND London
    17th Floor
    England
    EnglandBritishDirector192240500001
    O'GORMAN, Hannah
    5th Floor
    33 Cannon Street
    EC4M 5SB London
    Dalmore Capital Limited, Watling House
    England
    Director
    5th Floor
    33 Cannon Street
    EC4M 5SB London
    Dalmore Capital Limited, Watling House
    England
    United KingdomBritishDirector313750000002
    PATEL, Rajeshree
    Flat 19 45 Barkston Gardens
    SW5 0ES London
    Director
    Flat 19 45 Barkston Gardens
    SW5 0ES London
    United KingdomBritishCommercial Director100502650001
    PEARCE, Gregory David, Mr.
    Flat 2 Moorcroft
    Elgin Road
    KT13 8TR Weybridge
    Surrey
    Director
    Flat 2 Moorcroft
    Elgin Road
    KT13 8TR Weybridge
    Surrey
    EnglandAustralian/BritishBanker100974270001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Healthcare Support (Newcastle) Holdings Limited
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies For England And Wales
    Número de registro04420880
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental legal mortgage
    Creado el 09 oct 2009
    Entregado el 15 oct 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the project co debenture beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Units F1 and F2 at the freeman hospital newcastle and retail unit 1 retail unit 2 retail unit 3 retail unit 4 east cafe (unit 5) west cafe (unit 6) at the newcastle royal victoria infirmary hospital newcastle see image for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 15 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 04 may 2005
    Entregado el 13 may 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the project co debenture beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for Itself and the Other Project Codebenture Beneficiaries
    Transacciones
    • 13 may 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 25 feb 2004
    Entregado el 28 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The premises known as the freeman mulit-storey car park freeman hospital newcastle upon tyne and all rights relating to other property, the contracts, the benefit of performance bonds, the plant and machinery, the goodwill and by way of floating charge all the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0