HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04401832 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 Park Row LS1 5AB Leeds United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LAING INVESTMENTS UTILITIES HOLDINGS LIMITED | 22 mar 2002 | 22 mar 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 17 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 32 páginas | AA | ||
Modification des détails de Healthcare Support (Newcastle) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Watling House 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB United Kingdom a 1 Park Row Leeds LS1 5AB el 23 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Hannah O'gorman como director el 26 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr John Mcdonagh como director el 26 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Modification des détails de Healthcare Support (Newcastle) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 8 White Oak Square London Road Swanley BR8 7AG England a Watling House 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB el 11 ago 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Vercity Social Infrastructure (Uk) Limited como secretario el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Mr Alastair James Watson el 27 jun 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 32 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Hcp Social Infrastructure (Uk) Limited el 23 abr 2021 | 1 páginas | CH04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 31 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Ms Hannah O'gorman el 17 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 27 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr John Stephen Gordon el 02 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESOLIS LIMITED | Secretario corporativo | 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited, 11th Floor, Exchange Tower Scotland |
| 285489620001 | ||||||||||
BIRLEY-SMITH, Gaynor | Director | 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House England | United Kingdom | British | Investment Director | 126862310004 | ||||||||
GORDON, John Stephen | Director | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | Director | 203724200001 | ||||||||
MCDONAGH, John | Director | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh 2nd Floor Caledonian Exchange United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 192240500002 | ||||||||
WATSON, Alastair James | Director | Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House 91-93 England England | United Kingdom | British | Investment Director | 164639450002 | ||||||||
LEWIS, Maria | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 152623490001 | ||||||||||
LIMITED, Resolis | Secretario | 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower Scotland | 298975460001 | |||||||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||||||
NAYLOR, Philip | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 201612300001 | |||||||||||
SHELL, Peter Geoffrey | Secretario | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||||||
VERCITY SOCIAL INFRASTRUCTURE (UK) LIMITED | Secretario corporativo | White Oak Square, London Road BR8 7AG Swanley 8 England |
| 137166280005 | ||||||||||
ASTERAKI, David John | Director | St James Park Road Toddington LU5 6AB Dunstable Bedfordshire | British | Bank Executive | 50983030001 | |||||||||
BAYBUTT, Michael | Director | 33 Curtis Wood Park Road CT6 7TY Herne Bay Kent | United Kingdom | British | Operations Manager | 74962840001 | ||||||||
BERTHOU, Nicole | Director | 3/12-16 Billyard Avenue Elizabeth Bay Nsw 2011 Australia | Australian | Solutions Executive Private Ca | 101327730001 | |||||||||
BLISS, Nicholas John | Director | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 England | England | British | Solicitor | 218622920001 | ||||||||
BRADBURY, David Richard | Director | London Road BR8 7AG Swanley 8 White Oak Square England | United Kingdom | British | Asset Director | 109853290004 | ||||||||
CROWTHER, Nicholas John Edward | Director | c/o Innisfree Limited 91/93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House England | United Kingdom | British | Director | 103617880001 | ||||||||
CUTTANCE, Paul Francis, Mr. | Director | 47 Burlington Gardens TW9 4DG Richmond Surrey | Australian | Executive Manager Of Project A | 101327350003 | |||||||||
ELDRIDGE, James, Mr. | Director | The New House Aspen Close KT11 3AD Cobham Surrey | England | Australian | Banking Executive | 125881500001 | ||||||||
FREW, Leilani Mae | Director | 6 Eglinton Road, Glebe FOREIGN Sydney New South Wales 2037 Australia | New Zealand | Solution Executive | 107705930001 | |||||||||
GRAHAM, John | Director | c/o Innisfree Limited 91/93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House England | United Kingdom | British | Investment Director | 116875070001 | ||||||||
HARDY, David Michael | Director | 8 Lansdowne Circus CV32 4SW Leamington Spa Warwickshire | British | Chartered Accountant | 106339430001 | |||||||||
HARRIS, John David | Director | Aldersgate Street EC1A 4HD London 17th Floor 200 United Kingdom | England | British | Director | 174333200001 | ||||||||
HEATH, James Christopher | Director | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 England | United Kingdom | British | Director | 122413700002 | ||||||||
HUDSON, Ian David | Director | Allington House 150 Victoria Street SW1E 5LB London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 126636920001 | ||||||||
JONES, Stephen Michael | Director | 9 Silver Crescent Chiswick W4 5SF London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 88268290001 | ||||||||
LINNEY, Joseph Mark | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | Scotland | British | Chartered Quantity Surveyor | 63161960001 | ||||||||
LOWRY, Steven | Director | 8a Broomfield Road TW9 3HR Kew Surrey | British | Banker | 112028520001 | |||||||||
LUCAS, Gary Stephen | Director | 18 Willoughby Way Piddington NN7 2EH Northamptonshire | England | British | Associate Director | 70621740001 | ||||||||
MARSDEN, Robert James | Director | Park House 2 Dee Hills Park CH3 5AR Chester | England | British | Projects Director | 86971250002 | ||||||||
MCDONAGH, John | Director | c/o Dalmore Capital Limited 200 Aldersgate Street EC1A 2ND London 17th Floor England | England | British | Director | 192240500001 | ||||||||
O'GORMAN, Hannah | Director | 5th Floor 33 Cannon Street EC4M 5SB London Dalmore Capital Limited, Watling House England | United Kingdom | British | Director | 313750000002 | ||||||||
PATEL, Rajeshree | Director | Flat 19 45 Barkston Gardens SW5 0ES London | United Kingdom | British | Commercial Director | 100502650001 | ||||||||
PEARCE, Gregory David, Mr. | Director | Flat 2 Moorcroft Elgin Road KT13 8TR Weybridge Surrey | England | Australian/British | Banker | 100974270001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare Support (Newcastle) Holdings Limited | 06 abr 2016 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene HEALTHCARE SUPPORT (NEWCASTLE) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental legal mortgage | Creado el 09 oct 2009 Entregado el 15 oct 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the project co debenture beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Units F1 and F2 at the freeman hospital newcastle and retail unit 1 retail unit 2 retail unit 3 retail unit 4 east cafe (unit 5) west cafe (unit 6) at the newcastle royal victoria infirmary hospital newcastle see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 04 may 2005 Entregado el 13 may 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the project co debenture beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 25 feb 2004 Entregado el 28 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The premises known as the freeman mulit-storey car park freeman hospital newcastle upon tyne and all rights relating to other property, the contracts, the benefit of performance bonds, the plant and machinery, the goodwill and by way of floating charge all the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0