KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED

KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04409733
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Nuffield House
    41-46 Piccadilly
    W1J 0DS London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SALTERS DROITWICH (NOMINEE NO 2) LIMITED22 may 200222 may 2002
    T OFFICE NOMINEES LIMITED05 abr 200205 abr 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 may 2012

    Estado de capital el 01 may 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2010 au 30 jun 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Michael Creak el 02 may 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Michael Creak el 02 may 2011

    2 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Michael Tyler como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    15 páginas395

    Resoluciones

    Resolutions
    18 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CREAK, Michael
    New Park Road
    GU6 7HL Cranleigh
    Whitehaven
    United Kingdom
    Secretario
    New Park Road
    GU6 7HL Cranleigh
    Whitehaven
    United Kingdom
    Other118743590001
    CREAK, Michael Jonathan
    New Park Road
    GU6 7HL Cranleigh
    Whitehaven
    United Kingdom
    Director
    New Park Road
    GU6 7HL Cranleigh
    Whitehaven
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant118743590002
    HILL, Amanda Jane
    Quinton Street
    Earlsfield
    SW18 3QS London
    60a
    Director
    Quinton Street
    Earlsfield
    SW18 3QS London
    60a
    United KingdomBritishProperty Investment105932470001
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Secretario
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    MCGANN, Martin Francis
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    Secretario
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    BritishChartered Accountant109383240002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Secretario corporativo
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TEMPLE SECRETARIAL LIMITED
    16 Old Bailey
    EC4M 7EG London
    Secretario corporativo
    16 Old Bailey
    EC4M 7EG London
    73539310001
    ARNOLD, Jeremy Patrick
    1 Pentire Close
    Shores Road
    GU21 4PZ Woking
    Surrey
    Director
    1 Pentire Close
    Shores Road
    GU21 4PZ Woking
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor101568980001
    DALE, James Hall
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Director
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Accountant84675480001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Director
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritishChartered Accountant32807790002
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Director
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritishChartered Surveyor76584200002
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Director
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritishDirector23621230001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Director
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official62939740001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Director
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritishEconomist73817060002
    MARCOVECCHIO, Massimo Mario
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Director
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor75936930001
    MCGANN, Martin Francis
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    Director
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    EnglandBritishChartered Accountant109383240002
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Director
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCh Surveyor41216370001
    TYLER, Michael Peters
    Haydon Park Road
    SW19 8JH London
    99
    Director
    Haydon Park Road
    SW19 8JH London
    99
    BritishChartered Surveyor108051840001
    WISE, David Andrew John
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    Director
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    United KingdomBritishChartered Surveyor74016310001
    WOMACK, Ian Bryan
    Fetherston House
    Walnut Hill Surlingham
    NR14 7DQ Norwich
    Norfolk
    Director
    Fetherston House
    Walnut Hill Surlingham
    NR14 7DQ Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official33902000001
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Director corporativo
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    CGNU DIRECTOR SERVICES LIMITED
    St Helen`S 1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Director corporativo
    St Helen`S 1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    60496090002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene KANDAHAR (DROITWICH) NOMINEE NO.2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 jul 2007
    Entregado el 31 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 jul 2007Registro de un cargo (395)
    A security agreement
    Creado el 16 mar 2004
    Entregado el 01 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of legal mortgage the freehold property being salters shopping centre st andrews square droitwich t/n HW137458 by way of fixed charge all plant and machinery book and other debts uncalled capital and goodwill by way of floating charge all undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston
    Transacciones
    • 01 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 oct 2002
    Entregado el 21 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the borrowers and the property owners to the chargee as agent and trustee for the secured parties (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited
    Transacciones
    • 21 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0