RED BREEZE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRED BREEZE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04410217
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RED BREEZE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra RED BREEZE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RED BREEZE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RED BREEZE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    38 páginasLIQ13

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 14 jul 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 jun 2017

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cambio de datos del director Valsec Director Limited el 24 feb 2017

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Valad Secretarial Services Limited el 24 feb 2017

    1 páginasCH04

    Nombramiento de Ms Ciara Fitzgibbon como director el 24 feb 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Kenneth Robertson como director el 24 feb 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 abr 2016

    Estado de capital el 08 abr 2016

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Cese del nombramiento de Claire Treacy como director el 05 ene 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Neil Kenneth Robertson como director el 05 ene 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Claire Treacy como director el 14 ago 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Fraser James Kennedy como director el 14 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 abr 2015

    Estado de capital el 10 abr 2015

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 abr 2014

    Estado de capital el 11 abr 2014

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de RED BREEZE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC219311
    133355520004
    FITZGIBBON, Ciara
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish225576850001
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director corporativo
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5307786
    102622300003
    NAIK, Varsha
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    Secretario
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    British101693390001
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    Secretario corporativo
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    42871950001
    BOWMAN, Gary John
    Le Pre Du Haut
    Rue De Grantez
    JE3 4DG St Owen
    Jersey
    Channel Islands
    Director
    Le Pre Du Haut
    Rue De Grantez
    JE3 4DG St Owen
    Jersey
    Channel Islands
    British79684770002
    CAPPS, David John
    Shibui
    Route De La Villaise
    JE3 2AP Millais
    St Ouen
    Jersey
    Director
    Shibui
    Route De La Villaise
    JE3 2AP Millais
    St Ouen
    Jersey
    British75686940005
    COOMBS-GOODFELLOW, Ian Christopher
    Sandhurst Causie Drive
    St Clement
    JE2 6SR Jersey
    Channel Islands
    Director
    Sandhurst Causie Drive
    St Clement
    JE2 6SR Jersey
    Channel Islands
    British79683160001
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish72399980002
    FENNELL, Darren James
    Wiggins Cottage
    Goosey
    SN7 8PA Faringdon
    Oxfordshire
    Director
    Wiggins Cottage
    Goosey
    SN7 8PA Faringdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish64532590001
    KENNEDY, Fraser James
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    OLIVER, Paul Francis
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    Director
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    United KingdomBritish14735150002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Director
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    THOMAS, Andrew James
    Longueville Road, St Saviour
    JE2 7WF Jersey
    Channel Islands
    Director
    Longueville Road, St Saviour
    JE2 7WF Jersey
    Channel Islands
    British79683170001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Director
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    British100816670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RED BREEZE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Equity Partnerships (Osprey) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06 abr 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro4299729
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene RED BREEZE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 10 feb 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the south side of king edward street macclesfield t/n CH393674, l/h land on the north east queen street (k/a regent house) barnstaple and l/h land being part of multi-storey car park queen street barnstaple t/n DN276066 and DN311311 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 31 jul 2002
    Entregado el 02 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the osprey limited partnership acting by its general partner equity partnerships (osprey) limited to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The l/h property k/a 63-71 high street, andover. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 02 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 31 jul 2002
    Entregado el 02 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 02 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene RED BREEZE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jun 2017Inicio de la liquidación
    14 abr 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0