NORD UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNORD UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04411175
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NORD UK LIMITED?

    • Otra educación n.c.p. (85590) / Educación

    ¿Dónde se encuentra NORD UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORD UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEAPFROG DAY NURSERIES LIMITED09 jun 200409 jun 2004
    LEAPFROG DAY NURSERIES PLC02 may 200202 may 2002
    FUNQUEST PLC08 abr 200208 abr 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NORD UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORD UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de The Old Vicarage Market Street Castle Donington Derbyshire DE74 2JB United Kingdom el 31 jul 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 jul 2012

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2011

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de The Old Vicarage Market Street Castle Donington Derby DE74 2JB United Kingdom el 22 may 2012

    1 páginasAD01

    legacy

    3 páginasMG02

    Domicilio social registrado cambiado de The Old Vicarage Market Street Castle Donington Derby DE74 2JB United Kingdom el 14 abr 2012

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Nord House Third Avenue Centrum 100 Burton-upon-Trent Staffordshire Staffordshire DE14 2WD United Kingdom el 14 abr 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 oct 2011

    Estado de capital el 20 oct 2011

    • Capital: GBP 17,827,803.8
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2010

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Graeme Robert Halder como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Smith como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Smith como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Andrew Fitzmaurice el 29 oct 2009

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginas403a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2008

    14 páginasAA

    legacy

    18 páginas395

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de NORD UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FITZMAURICE, Andrew
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Director
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    EnglandBritish70922490002
    HALDER, Graeme Robert
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Director
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Hong Kong, ChinaBritish154739000001
    BUTCHER, Michael Leonard
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Secretario
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    British43307770001
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British73116190002
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British73116190002
    MEAD, Richard Barwick
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    British44255220002
    METCALF, Hannah Ruth
    Addleshaw Goddard
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Lancashire
    Secretario
    Addleshaw Goddard
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Lancashire
    British114415480001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Secretario
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British51283590002
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    British124619670001
    TARN, Elizabeth Jill
    Flat 10 Rosemount House
    15a Poplar Road Dorridge
    B93 8DD Solihull
    Secretario
    Flat 10 Rosemount House
    15a Poplar Road Dorridge
    B93 8DD Solihull
    British92051440005
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Secretario designado corporativo
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BUTCHER, Michael Leonard
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Director
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    British43307770001
    HAWKINS, Ian Roger
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    Director
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    British15991450002
    HUSBANDS, Susan Dawn
    Severn Cottage 24 Buildwas Road
    Ironbridge
    TF8 7DW Telford
    Salop
    Director
    Severn Cottage 24 Buildwas Road
    Ironbridge
    TF8 7DW Telford
    Salop
    British57874840001
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Director
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British73116190002
    MAPP, Derek
    Sudbrook Hall
    Nesfield, Barlow
    S18 7TB Dronfield
    Derbyshire
    Director
    Sudbrook Hall
    Nesfield, Barlow
    S18 7TB Dronfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish12473610002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Director
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British87585160002
    MCNEANY, Kevin Joseph
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    Director
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    EnglandIrish2299150001
    MEAD, Richard Barwick
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish44255220002
    NOTT, Gillian
    3 St Peters Square
    W6 9AB London
    Director
    3 St Peters Square
    W6 9AB London
    EnglandBritish37051540002
    ROBINSON, Clive William
    16 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Surrey
    Director
    16 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Surrey
    EnglandBritish13438180002
    SELVEY, Anthony Rochford
    14 Monterey Close
    DA5 2BX Bexley
    Kent
    Director
    14 Monterey Close
    DA5 2BX Bexley
    Kent
    British6037980001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Director
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British51283590002
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish124619670001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    Director corporativo
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    77390740003
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    Director designado corporativo
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    ¿Tiene NORD UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Accession deed
    Creado el 10 oct 2008
    Entregado el 28 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse, Singapore Branch (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 28 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 jun 2007
    Entregado el 21 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 21 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 may 2006
    Entregado el 01 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 01 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 11 jun 2004
    Entregado el 17 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 17 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debentur e dated 1 april 1998
    Creado el 09 jul 2002
    Entregado el 25 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies from time to time owing due or to become due from the charging companies to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NORD UK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jul 2012Inicio de la liquidación
    23 oct 2013Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Profesional
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0