DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED

DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04413747
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit 12 Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE SPECIALIST HIRE GROUP LIMITED18 nov 200218 nov 2002
    BROOMCO (2898) LIMITED10 abr 200210 abr 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 07 dic 2022

    • Capital: GBP 0.50
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share premium account 07/12/2022
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    Re: the sum of £5,200 is hereby capitalised 05/12/2022
    RES14
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 dic 2022

    • Capital: GBP 348,081
    3 páginasSH01

    Nombramiento de Damien Joos De Ter Beerst como director el 23 ago 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Chankyo Chung como director el 01 ago 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    19 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Sangyoung Park como director el 05 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jae Hun Lee como director el 05 feb 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Chankyo Chung como director el 14 feb 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David John Clarkson como director el 14 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr David John Clarkson el 28 sept 2018

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Timothy Mark Waples como director el 28 sept 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JOOS DE TER BEERST, Damien
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    BelgiumBelgian299677480001
    PARK, Sangyoung
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandSouth Korean279587030001
    COSGROVE, Lynn
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Secretario
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    British82671660002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    CHAPPELL, John
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    United KingdomBritish82671440009
    CHUNG, Chankyo
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    BelgiumSouth Korean267295790001
    CLARKSON, David John
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandBritish226255820001
    COSGROVE, Peter
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    EnglandBritish82678990001
    FARQUHAR, Graham
    Ravensthorpe Industrial Estate
    Huddersfield Road, Ravensthorpe
    WF13 3LN Dewsbury
    Rushlift Ltd
    Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Ravensthorpe Industrial Estate
    Huddersfield Road, Ravensthorpe
    WF13 3LN Dewsbury
    Rushlift Ltd
    Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133936050001
    FARQUHAR, Graham
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    United KingdomBritish133936050001
    HOLYLAND, Graham Anthony
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    EnglandBritish117529920002
    LEE, Jae Hun
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandSouth Korean200052720001
    LOKE, Joanna
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    United KingdomEnglish195167270001
    SHAW, Dennis Charles
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandBritish87833070001
    SUH, Sungkyo
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    SeoulSouth Korean195430480001
    WAPLES, Timothy Mark
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Director
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    EnglandBritish126815020001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    NOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LIMITED
    Floor Dorey Court Admiral Park
    St Peter Port
    GY1 6HJ Guernsey
    1st
    Channel Islands
    Director corporativo
    Floor Dorey Court Admiral Park
    St Peter Port
    GY1 6HJ Guernsey
    1st
    Channel Islands
    Forma jurídicaNOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LTD
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalLIMITED COMPANY
    Número de registro44635
    130880920001
    NOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LTD
    Strand
    SW1Y 5HF London
    11
    Director corporativo
    Strand
    SW1Y 5HF London
    11
    115027450004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Doosan Industrial Vehicle Uk Ltd
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    12
    England
    06 abr 2016
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    12
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalLtd Companies Act 2006
    Lugar de registroEngland
    Número de registro7646794
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 mar 2011
    Entregado el 06 abr 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land adjoining northgate, white lund industrial estate, morecambe t/n LA926044,fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of further properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC and Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 06 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 25 feb 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    Legal mortgage
    Creado el 25 mar 2011
    Entregado el 01 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 3 south church industrial estate bishop auckland and land at longfield road south church enterprise park bishop auckland t/nos. DU156261 and DU253443 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 25 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 25 mar 2011
    Entregado el 01 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Northgate white lund industrial estate morecambe t/no. LA926044 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 25 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 31 ago 2006
    Entregado el 15 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property k/a northgate white lund industrial estate morecambe lancashire t/no LA926044. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 31 ago 2006
    Entregado el 15 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 3 south church industrial estate bishop auckland county durham t/no DU156261 and adjoining land t/no DU253443. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 nov 2002
    Entregado el 22 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (2898) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of life policy
    Creado el 17 jul 2002
    Entregado el 20 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Halifax life policy number ASSH002071 commenced on 24 june 2002 in respect of peter cosgrove together with all sums assured by the policy and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right title and interest present and future in the policy.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of life policy
    Creado el 17 jul 2002
    Entregado el 20 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Halifax life policy number ASSH002070 commenced on 24 june 2002 in respect of john chappell together with all sums assured by the policy and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right title and interest present and future in the policy.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 11 jun 2002
    Entregado el 15 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0