COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04414666 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SYDNEY & BIRMINGHAM 1 LIMITED | 11 abr 2002 | 11 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 43 páginas | 4.71 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Kenneth Robertson como director el 24 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 11 abr 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Kenneth Robertson como director el 05 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Treacy como director el 05 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Claire Treacy como director el 14 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Fraser James Kennedy como director el 14 ago 2015 | 1 p áginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Valsec Director Limited el 01 jul 2013 | 2 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Fraser James Kennedy el 01 jul 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* el 02 jul 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520001 | ||||||||||
| VALSEC DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom |
| 102622300002 | ||||||||||
| CURTIS, Wendy June | Secretario | 136 Henke Court Schooner Way Atlantic Wharf CF10 4EL Cardiff | British | 46982690003 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Secretario | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| CHALFEN SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013320001 | |||||||||||
| ANNING, Richard John | Director | Witchwood Westra CF64 4HA Dinas Powys Vale Of Glamorgan | Wales | British | 14073020003 | |||||||||
| CHILDS, Simon John | Director | 18 Hardwicke Court Llandaff CF5 2LB Cardiff | Wales | British | 78425720001 | |||||||||
| CURTIS, Wendy June | Director | 136 Henke Court Schooner Way Atlantic Wharf CF10 4EL Cardiff | British | 46982690003 | ||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Director | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Director | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Director | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Director | Esplanade YO11 2AQ Scarborough 20 Europa House North Yorkshire | England | British | 135717740001 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Director | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Director | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| CHALFEN NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013310001 | |||||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
¿Tiene COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 22 mar 2012 Entregado el 30 mar 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 all saints road wednesbury t/no WM695818 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession and charge | Creado el 28 ago 2009 Entregado el 11 sept 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 08 nov 2002 Entregado el 22 nov 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 nov 2002 Entregado el 22 nov 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998) | Creado el 16 abr 2002 Entregado el 27 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to the lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge over shares | Creado el 16 abr 2002 Entregado el 27 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental deed | Creado el 16 abr 2002 Adquirido el 16 abr 2002 Entregado el 24 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0