COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED

COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04414666
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SYDNEY & BIRMINGHAM 1 LIMITED11 abr 200211 abr 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    43 páginas4.71

    Cese del nombramiento de Neil Kenneth Robertson como director el 24 feb 2017

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 11 abr 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 22 mar 2016

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015

    3 páginasAA

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Neil Kenneth Robertson como director el 05 ene 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Claire Treacy como director el 05 ene 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Claire Treacy como director el 14 ago 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Fraser James Kennedy como director el 14 ago 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 11 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 abr 2015

    Estado de capital el 24 abr 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 abr 2014

    Estado de capital el 16 abr 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Valsec Director Limited el 01 jul 2013

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del director Mr Fraser James Kennedy el 01 jul 2013

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* el 02 jul 2013

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 11 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director corporativo
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5307786
    102622300002
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    Secretario
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    British46982690003
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    CHALFEN SECRETARIES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    Secretario designado corporativo
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013320001
    ANNING, Richard John
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    Director
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritish14073020003
    CHILDS, Simon John
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    Director
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    WalesBritish78425720001
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    Director
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    British46982690003
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    20 Europa House
    North Yorkshire
    Director
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    20 Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Director
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Director
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    CHALFEN NOMINEES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    Director designado corporativo
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013310001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director corporativo
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    ¿Tiene COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 30 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 all saints road wednesbury t/no WM695818 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 30 mar 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 12 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creado el 28 ago 2009
    Entregado el 11 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 11 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 08 nov 2002
    Entregado el 22 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 08 nov 2002
    Entregado el 22 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998)
    Creado el 16 abr 2002
    Entregado el 27 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to the lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 27 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over shares
    Creado el 16 abr 2002
    Entregado el 27 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 27 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 16 abr 2002
    Adquirido el 16 abr 2002
    Entregado el 24 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 24 abr 2002Registro de una adquisición (400)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene COLERIDGE (WEDNESBURY 1) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 mar 2016Inicio de la liquidación
    30 jul 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0