MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04415196 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOVELL RESPOND LIMITED | 01 abr 2009 | 01 abr 2009 |
| BMS PROPERTY CARE LIMITED | 12 abr 2002 | 12 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Patrick Denis Boyle el 01 dic 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Lisa Ann Katherine Minns como secretario el 03 jun 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Helen Mary Mason como secretario el 22 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 45 páginas | AA | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 25 nov 2024
| 3 páginas | SH01 | ||
Cese del nombramiento de Clare Sheridan como secretario el 27 jun 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mrs Helen Mary Mason como secretario el 27 jun 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Culdip Kelly Kaur Gangotra como director el 07 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Paul Crummett como director el 07 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Joanne Jamieson como director el 23 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 41 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Paul David Reader como director el 09 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 42 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Darren Robert Eaton como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Simon William Butler como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Natasha Kyriakou como director el 28 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Khalid Nawaz como director el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Patrick Denis Boyle como director el 28 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alan Hayward como director el 28 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Philip James Copperwheat como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Paul David Reader el 25 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Natasha Kyriakou el 25 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINNS, Lisa Ann Katherine | Secretario | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | 336525890001 | |||||||
| BOYLE, Patrick Denis | Director | Cooper House, Redgrave Close Cross Point Business Park CV2 2UU Coventry Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | 186120400001 | |||||
| BUTLER, Simon William | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | United Kingdom | British | 313026420001 | |||||
| EATON, Darren Robert | Director | Nottingham Business Park NG8 6PY Nottingham Unit H6 - Morgan Sindall United Kingdom | United Kingdom | British | 313151430001 | |||||
| GANGOTRA, Culdip Kelly Kaur | Director | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 180304190002 | |||||
| JAMIESON, Joanne | Director | Hawke Street Hawke Street Business Park S9 2SU Sheffield 1 South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 322337540001 | |||||
| MORGAN, John Christopher | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | England | British | 7146080002 | |||||
| BATTRUM, Andrew | Secretario | Woodbine Cottage WR6 5RT Whitbourne Worcestershire | British | 81780530001 | ||||||
| JONES, Philippa Mary | Secretario | 2 Mount Pleasant DY6 9SE Kingswinford West Midlands | British | 114432520002 | ||||||
| MASON, Helen Mary | Secretario | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | 324738820001 | |||||||
| NETTLESHIP, Isobel Mary | Secretario | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | British | 147086990001 | ||||||
| SHERIDAN, Clare | Secretario | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | 188474600001 | |||||||
| WALFORD, Elizabeth Mary | Secretario | Bannuttree House Cross Lane Head Astley Abbots WV16 4SJ Bridgnorth Salop | British | 104107680001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BATTRUM, Andrew | Director | Woodbine Cottage WR6 5RT Whitbourne Worcestershire | England | British | 81780530001 | |||||
| CODLING, Robert Eric | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | British | 71381970001 | ||||||
| COPPERWHEAT, Philip James | Director | London Wall EC2M 7AD London 85 United Kingdom | United Kingdom | British | 192653830001 | |||||
| COX, Marcus Edward | Director | Valiant House 4-10 Heneage Lane EC3A 5DQ London 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 246075070001 | |||||
| CRUMMETT, Stephen Paul | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | England | British | 177741840001 | |||||
| CUMMINS, Nicholas | Director | Bracken Ways Studley Nr Coreley SY8 3NP Ludlow Shropshire | British | 111946970001 | ||||||
| DAVENPORT, Ivor Stewart | Director | Bonehill Road B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 44015420004 | |||||
| DUDGEON, Richard Gregory | Director | Forgotten Well School Lane Weston Under Lizard TF11 8JZ Shifnal Shropshire | England | British | 111890420001 | |||||
| HANN, Nick | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | United Kingdom | British | 192434290001 | |||||
| HAYWARD, Alan | Director | London Wall EC2M 7AD London 85 United Kingdom | England | British | 240163800002 | |||||
| HIGGINBOTTOM, John Nigel | Director | Don Road S9 2UB Sheffield Riverside House England And Wales United Kingdom | England | British | 236793570001 | |||||
| JONES, Marcus Faughey | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | England | British | 69189090002 | |||||
| KAY, William George | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | England | British | 221612110001 | |||||
| KENT, Michael Jonathan | Director | 2 Clydesdale Court, Kings Lane Snitterfield CV7 7BH Stratford Upon Avon West Midlands | United Kingdom | British | 188807870001 | |||||
| KNIGHT, Samantha | Director | 4-10 Heneage Lane EC3A 5DQ London Valiant House United Kingdom | United Kingdom | British | 260844920001 | |||||
| KNOWLES, Frederick Anthony Wakefield | Director | Little Eslington Thirlestaine Road GL53 7AS Cheltenham Gloucestershire | British | 29445400001 | ||||||
| KYRIAKOU, Natasha | Director | London Wall EC2M 7AD London 85 United Kingdom | United Kingdom | British | 270927540001 | |||||
| LEARY, John Christopher | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | England | British | 162123350001 | |||||
| LESTER, Gary Thomas | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | England | British | 173965540001 | |||||
| LEWIS, Mark Andrew | Director | Bonehill Road B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | England | British | 135597890002 | |||||
| MULLIGAN, David Kevin | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House | England | British | 74215210003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MORGAN SINDALL PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Sindall Group Plc | 06 abr 2016 | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0