ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04416668 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32500) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Dirección de la sede social | Vernacare 1 Western Avenue Matrix Park PR7 7NB Buckshaw Village Chorley England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CASTLEGATE 222 LIMITED | 15 abr 2002 | 15 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 29 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2025 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 044166680002 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven David Brewster como director el 14 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Ms Nicola Boulton el 13 jul 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Steven David Brewster como director el 23 feb 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Alexander Weld Hodges como director el 17 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy David Wadhams como director el 17 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de James Steele como director el 14 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Martin Wright como director el 31 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Andrew Hall como director el 30 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 34 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Registro de la carga 044166680002, creada el 30 sept 2021 | 16 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Western Avenue Buckshaw Village Matrix Park Chorley PR7 7NB a Vernacare 1 Western Avenue Matrix Park Buckshaw Village Chorley PR7 7NB el 06 jul 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Nicola Boulton como director el 02 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Martin Wright como director el 02 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, Richard Andrew | Director | 1 Western Avenue Matrix Park PR7 7NB Buckshaw Village Vernacare Chorley England | England | British | 140773950001 | |||||
| HODGES, Alexander Weld | Director | 1 Western Avenue Matrix Park PR7 7NB Buckshaw Village Vernacare Chorley England | England | American | 303249470001 | |||||
| MORRIS, Nicola Spencer | Director | Buckshaw Village Matrix Park PR7 7NB Chorley 1 Western Avenue Lancashire England | England | British | 264744050002 | |||||
| WADHAMS, Timothy David | Director | 1 Western Avenue Matrix Park PR7 7NB Buckshaw Village Vernacare Chorley England | England | British | 303250220001 | |||||
| ASQUITH, Mark Anthony | Secretario | Retford Road S13 9LE Sheffield 50 South Yorkshire | British | 116436840005 | ||||||
| BARTON, Robert John | Secretario | Sheepwalk Lane Ravenshead NG15 9FD Nottingham 35 Nottinghamshire | British | 136554260001 | ||||||
| BELL, James | Secretario | 6 Sovereign Way DE75 7SB Heanor Derbyshire | British | 65643310002 | ||||||
| MILLER, Christopher Hugh | Secretario | 2 Rushcliffe Avenue Radcliffe On Trent NG12 2AF Nottingham | British | 8071340001 | ||||||
| RICHARDSON, Mark | Secretario | Church Road Barnby Dun DN3 1BD Doncaster 63 South Yorkshire United Kingdom | British | 147338340001 | ||||||
| THOMASSON, Leigh | Secretario | Alderson Drive Tickhill DN11 9HR Doncaster 2 South Yorkshire | United Kingdom | 41994080004 | ||||||
| WATSON, Terence | Secretario | 128 Lambley Lane Burton Joyce NG14 5BN Nottingham | British | 17367130002 | ||||||
| CASTLEGATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Castle Gate NG1 7BJ Nottingham 44 Nottinghamshire | 128872830001 | |||||||
| ASQUITH, Mark Anthony | Director | Retford Road S13 9LE Sheffield 50 South Yorkshire | England | British | 116436840005 | |||||
| BARTON, Robert John | Director | Sheepwalk Lane Ravenshead NG15 9FD Nottingham 35 Nottinghamshire | England | British | 136554260001 | |||||
| BELL, James | Director | 6 Sovereign Way DE75 7SB Heanor Derbyshire | British | 65643310002 | ||||||
| BREWSTER, Steven David | Director | 1 Western Avenue Matrix Park PR7 7NB Buckshaw Village Vernacare Chorley England | Scotland | British | 127184990002 | |||||
| HALL, Richard Andrew | Director | Western Avenue Buckshaw Village PR7 7NB Matrix Park 1 Chorley | England | British | 140773950001 | |||||
| JEFFREY, Nicholas | Director | Lawn Road Industrial Estate Carlton In Lindrick S81 9LB Worksop Unit 3 Nottinghamshire | England | British | 15639340001 | |||||
| LEWORTHY, Bruce George | Director | Risbon 11 The Butts Bratton BA13 4SW Westbury Wiltshire | United Kingdom | British | 34546950001 | |||||
| MILLER, Christopher Hugh | Director | 2 Rushcliffe Avenue Radcliffe On Trent NG12 2AF Nottingham | England | British | 8071340001 | |||||
| RICHARDSON, Mark | Director | Lawn Road Industrial Estate Carlton In Lindrick S81 9LB Worksop Unit 3 Nottinghamshire | England | English | 118901250003 | |||||
| SEWELL, Ian | Director | 16 Meadow Lea Sutton In Craven BD20 8BY Keighley West Yorkshire | England | British | 75586210001 | |||||
| SMITH, Gavin David | Director | Lawn Road Industrial Estate Carlton In Lindrick S81 9LB Worksop Unit 3 Nottinghamshire | England | British | 102540130003 | |||||
| STEELE, James | Director | Buckshaw Village Matrix Park PR7 7NB Chorley 1 Western Avenue England | England | British | 209099970003 | |||||
| THOMASSON, Leigh | Director | Lawn Road Industrial Estate Carlton In Lindrick S81 9LB Worksop Unit 3 Nottinghamshire | England | English | 41994080005 | |||||
| WALLIS, David William | Director | Low Garth Church Lane Collingham LS22 5AU Wetherby England | England | British | 48299920002 | |||||
| WALSH, Jonathan Thomas | Director | 171 Ashgate Rd Ashgate S40 4AN Chesterfield Derbyshire | British | 105755220001 | ||||||
| WATSON, Terence | Director | 128 Lambley Lane Burton Joyce NG14 5BN Nottingham | British | 17367130002 | ||||||
| WRIGHT, Paul Martin | Director | Buckshaw Village Matrix Park PR7 7NB Chorley 1 Western Avenue Lancashire England | England | British | 272226420001 | |||||
| CASTLEGATE DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | Castle Gate NG1 7BJ Nottingham 44 Nottinghamshire | 128874440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Leigh Thomasson | 16 abr 2016 | Lawn Road Industrial Estate Carlton In Lindrick S81 9LB Worksop Unit 3 Nottinghamshire | Sí | ||||
Nacionalidad: United Kingdom País de residencia: England | |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Robinson Healthcare Group Limited | 06 abr 2016 | Lawn Road Industrial Estate Carlton In Lindrick S81 9LB Workshop Unit 3 Nottinghamshire England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0