ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD

ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04416668
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    • Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32500) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    Dirección de la sede social
    Vernacare 1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Chorley
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CASTLEGATE 222 LIMITED15 abr 200215 abr 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta15 abr 2026
    Próxima declaración de confirmación vence29 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta15 abr 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2025

    10 páginasAA

    Cancelación total de la carga 044166680002

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Steven David Brewster como director el 14 mar 2025

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Ms Nicola Boulton el 13 jul 2024

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Steven David Brewster como director el 23 feb 2023

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    16 páginasAA

    Nombramiento de Mr Alexander Weld Hodges como director el 17 nov 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy David Wadhams como director el 17 nov 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Steele como director el 14 abr 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Paul Martin Wright como director el 31 ene 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Richard Andrew Hall como director el 30 sept 2021

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021

    14 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    34 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re-documents/deed/agent/co business 30/09/2021
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 044166680002, creada el 30 sept 2021

    16 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Western Avenue Buckshaw Village Matrix Park Chorley PR7 7NB a Vernacare 1 Western Avenue Matrix Park Buckshaw Village Chorley PR7 7NB el 06 jul 2021

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Nicola Boulton como director el 02 mar 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Martin Wright como director el 02 mar 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HALL, Richard Andrew
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    Director
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    EnglandBritish140773950001
    HODGES, Alexander Weld
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    Director
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    EnglandAmerican303249470001
    MORRIS, Nicola Spencer
    Buckshaw Village
    Matrix Park
    PR7 7NB Chorley
    1 Western Avenue
    Lancashire
    England
    Director
    Buckshaw Village
    Matrix Park
    PR7 7NB Chorley
    1 Western Avenue
    Lancashire
    England
    EnglandBritish264744050002
    WADHAMS, Timothy David
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    Director
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    EnglandBritish303250220001
    ASQUITH, Mark Anthony
    Retford Road
    S13 9LE Sheffield
    50
    South Yorkshire
    Secretario
    Retford Road
    S13 9LE Sheffield
    50
    South Yorkshire
    British116436840005
    BARTON, Robert John
    Sheepwalk Lane
    Ravenshead
    NG15 9FD Nottingham
    35
    Nottinghamshire
    Secretario
    Sheepwalk Lane
    Ravenshead
    NG15 9FD Nottingham
    35
    Nottinghamshire
    British136554260001
    BELL, James
    6 Sovereign Way
    DE75 7SB Heanor
    Derbyshire
    Secretario
    6 Sovereign Way
    DE75 7SB Heanor
    Derbyshire
    British65643310002
    MILLER, Christopher Hugh
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    Secretario
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    British8071340001
    RICHARDSON, Mark
    Church Road
    Barnby Dun
    DN3 1BD Doncaster
    63
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Church Road
    Barnby Dun
    DN3 1BD Doncaster
    63
    South Yorkshire
    United Kingdom
    British147338340001
    THOMASSON, Leigh
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    Secretario
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    United Kingdom41994080004
    WATSON, Terence
    128 Lambley Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BN Nottingham
    Secretario
    128 Lambley Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BN Nottingham
    British17367130002
    CASTLEGATE SECRETARIES LIMITED
    Castle Gate
    NG1 7BJ Nottingham
    44
    Nottinghamshire
    Secretario corporativo
    Castle Gate
    NG1 7BJ Nottingham
    44
    Nottinghamshire
    128872830001
    ASQUITH, Mark Anthony
    Retford Road
    S13 9LE Sheffield
    50
    South Yorkshire
    Director
    Retford Road
    S13 9LE Sheffield
    50
    South Yorkshire
    EnglandBritish116436840005
    BARTON, Robert John
    Sheepwalk Lane
    Ravenshead
    NG15 9FD Nottingham
    35
    Nottinghamshire
    Director
    Sheepwalk Lane
    Ravenshead
    NG15 9FD Nottingham
    35
    Nottinghamshire
    EnglandBritish136554260001
    BELL, James
    6 Sovereign Way
    DE75 7SB Heanor
    Derbyshire
    Director
    6 Sovereign Way
    DE75 7SB Heanor
    Derbyshire
    British65643310002
    BREWSTER, Steven David
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    Director
    1 Western Avenue
    Matrix Park
    PR7 7NB Buckshaw Village
    Vernacare
    Chorley
    England
    ScotlandBritish127184990002
    HALL, Richard Andrew
    Western Avenue
    Buckshaw Village
    PR7 7NB Matrix Park
    1
    Chorley
    Director
    Western Avenue
    Buckshaw Village
    PR7 7NB Matrix Park
    1
    Chorley
    EnglandBritish140773950001
    JEFFREY, Nicholas
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    Director
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    EnglandBritish15639340001
    LEWORTHY, Bruce George
    Risbon 11 The Butts
    Bratton
    BA13 4SW Westbury
    Wiltshire
    Director
    Risbon 11 The Butts
    Bratton
    BA13 4SW Westbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish34546950001
    MILLER, Christopher Hugh
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    Director
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    EnglandBritish8071340001
    RICHARDSON, Mark
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    Director
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    EnglandEnglish118901250003
    SEWELL, Ian
    16 Meadow Lea
    Sutton In Craven
    BD20 8BY Keighley
    West Yorkshire
    Director
    16 Meadow Lea
    Sutton In Craven
    BD20 8BY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish75586210001
    SMITH, Gavin David
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    Director
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    EnglandBritish102540130003
    STEELE, James
    Buckshaw Village
    Matrix Park
    PR7 7NB Chorley
    1 Western Avenue
    England
    Director
    Buckshaw Village
    Matrix Park
    PR7 7NB Chorley
    1 Western Avenue
    England
    EnglandBritish209099970003
    THOMASSON, Leigh
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    Director
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    EnglandEnglish41994080005
    WALLIS, David William
    Low Garth Church Lane
    Collingham
    LS22 5AU Wetherby
    England
    Director
    Low Garth Church Lane
    Collingham
    LS22 5AU Wetherby
    England
    EnglandBritish48299920002
    WALSH, Jonathan Thomas
    171 Ashgate Rd
    Ashgate
    S40 4AN Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    171 Ashgate Rd
    Ashgate
    S40 4AN Chesterfield
    Derbyshire
    British105755220001
    WATSON, Terence
    128 Lambley Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BN Nottingham
    Director
    128 Lambley Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BN Nottingham
    British17367130002
    WRIGHT, Paul Martin
    Buckshaw Village
    Matrix Park
    PR7 7NB Chorley
    1 Western Avenue
    Lancashire
    England
    Director
    Buckshaw Village
    Matrix Park
    PR7 7NB Chorley
    1 Western Avenue
    Lancashire
    England
    EnglandBritish272226420001
    CASTLEGATE DIRECTORS LIMITED
    Castle Gate
    NG1 7BJ Nottingham
    44
    Nottinghamshire
    Director corporativo
    Castle Gate
    NG1 7BJ Nottingham
    44
    Nottinghamshire
    128874440001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROBINSON HEALTHCARE HOLDINGS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Leigh Thomasson
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    16 abr 2016
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Worksop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    Nacionalidad: United Kingdom
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    Robinson Healthcare Group Limited
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Workshop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    England
    06 abr 2016
    Lawn Road Industrial Estate
    Carlton In Lindrick
    S81 9LB Workshop
    Unit 3
    Nottinghamshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalEngland And Wales
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0