DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04420831 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | 8 White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley Kent |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
EQUION DEFENCE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED | 19 abr 2002 | 19 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 19 nov 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Andrew Stephen Pearson como director el 13 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Hcp Management Services Ibex House 4th Floor West 42-47 Minories London EC3N 1DY a 8 White Oak Square London Road Swanley Kent, England BR8 7AG | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Teresa Sarah Hedges como secretario el 17 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Hcp Management Services Limited como secretario el 17 sept 2018 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 27 páginas | AA | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a C/O Hcp Management Services Ibex House 4th Floor West 42-47 Minories London EC3N 1DY | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Kingsway London WC2B 6AN a 8 White Oak Square London Road Swanley Kent BR8 7AG el 15 dic 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Naylor como secretario el 30 nov 2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Teresa Sarah Hedges como secretario el 30 nov 2016 | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 28 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent United Kingdom |
| 183851690001 | ||||||||||
PEARSON, Andrew Stephen | Director | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent | England | British | Managing Director | 91780000002 | ||||||||
WALKER, Guy Frederick | Director | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent | England | British | Accountant | 198546840001 | ||||||||
HEDGES, Teresa Sarah | Secretario | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent | 220689750001 | |||||||||||
LEWIS, Maria | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 172953490001 | ||||||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 120645920001 | ||||||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||||||
NAYLOR, Philip | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 201610150001 | |||||||||||
SHELL, Peter Geoffrey | Secretario | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||||||
BARRAS, Florence Marie Francoise | Director | 14 Rydon Street N1 7AL London | England | British,French | Investments Director | 58686720001 | ||||||||
CANN, John | Director | Oaklands Devauden NP16 6PE Chepstow Monmouthshire | British | Project Bid Manager | 84199540001 | |||||||||
COLVIN, Stuart Martin | Director | 55 Rutland Gardens BN3 5PD Hove East Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 99643100001 | ||||||||
CORPETTI, Christian Lucien | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | French | Portfolio Financial Controller | 163752540001 | ||||||||
GROOME, Richard Leonard | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 5670130001 | ||||||||
HOPE, Peter James | Director | New Road Weston Turville H22 5QT Aylesbury 83 Bucks | British | General Manager Defence | 128592920001 | |||||||||
JOHNSON, Dennis Arthur | Director | North Cottage Stede Hill Harrietsham ME17 1NP Maidstone Kent | British | Accountant | 12299810002 | |||||||||
JONES, Peter Donne | Director | The Red Barn Mounton Road NP16 6AA Chepstow Monmouthshire | British | Operations Manager | 75137020001 | |||||||||
LUCAS, Gary Stephen | Director | 18 Willoughby Way Piddington NN7 2EH Northamptonshire | England | British | Associate Director | 70621740001 | ||||||||
MCCOLL, Malcolm Duncan | Director | Flat 56 1 Prince Of Wales Road NW5 3LW London | British | Business Analyst | 78745680002 | |||||||||
MCKENZIE, Clive William Price | Director | 3 Warren Lodge Drive KT20 6QN Kingswood Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 78528180001 | ||||||||
ROPER, Anthony Charles | Director | Allington Grange Allington SN14 6LW Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | Investment Director | 62976440004 | ||||||||
WELLS, Ian Joseph | Director | 1 Grove Leys Grove Road HP23 5PB Tring Hertfordshire | British | Project Financier | 10730160001 | |||||||||
WESTON, Richard | Director | 5 Brackendale Grove Harpenden AL5 3EL St Albans Herts | British | Company Director | 48554340001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Laing Social Infrastructure Limited | 06 abr 2016 | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene DEFENCE SUPPORT (ST ATHAN) HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 31 jul 2003 Entregado el 15 ago 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrower and the charging company to the senior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all of the assigned assets all its freehold and leasehold interest in the properties together with all buildings fixtures the goodwill all intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge over shares and securities | Creado el 31 jul 2003 Entregado el 15 ago 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrower and the chargor to the senior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The chargor with full title guarantee charged the shares and securities and the derivative assets to the security trustee all beneficial interests in the charged property and to any proceeds of sale or other realisation of such property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0