CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04421200
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MERCURY HEALTH HOLDINGS LIMITED 25 nov 200325 nov 2003
    MERCURY HEALTH LIMITED28 feb 200328 feb 2003
    TRIBAL MANAGED SERVICES LIMITED 10 may 200210 may 2002
    OVAL (1725) LIMITED19 abr 200219 abr 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    13 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark Atkinson Hunt como director el 11 jul 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 19 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 may 2012

    Estado de capital el 01 may 2012

    • Capital: GBP 1,000,001
    SH01

    Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Care Uk Services Limited como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Andrew James Mackenzie Prosser como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Deans como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 19 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Paul Justin Humphreys el 01 abr 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    13 páginasAA

    Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    12 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    28 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 19 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Ian Deans como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del secretario Care Uk Services Limited el 01 abr 2010

    2 páginasCH04

    Nombramiento de Dr Mark Hunt como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Secretario
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    165449230001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish151240810001
    COLLINS, Richard Hawke
    5 Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    5 Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British53398040001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British68807890004
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2482660
    125332040002
    AICHROTH, Mark Jonathan Paul
    Bridge Farm
    West Lydford
    TA11 7DG Somerton
    Somerset
    Director
    Bridge Farm
    West Lydford
    TA11 7DG Somerton
    Somerset
    British93633880001
    BREACH, Stephen Derrick
    1 St Helens Avenue
    OX10 6RY Benson
    Oxfordshire
    Director
    1 St Helens Avenue
    OX10 6RY Benson
    Oxfordshire
    United KingdomBritish147928530001
    CHEVINS, David Geoffrey
    The Stables Tamhorn Park Farm
    Fisherwick Road
    WS14 9JJ Whittington
    Staffordshire
    Director
    The Stables Tamhorn Park Farm
    Fisherwick Road
    WS14 9JJ Whittington
    Staffordshire
    British29027400002
    DEANS, Ian David
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish133139220001
    HUNT, Mark Atkinson, Dr
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House
    850 The Crescent
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish129906070001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish68807890004
    MARTIN, Peter John
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wangrove
    Berkshire
    Director
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wangrove
    Berkshire
    EnglandBritish176044430001
    MCMILLAN, Jeanette Russell
    Schiehallion
    Featherbed Lane
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Schiehallion
    Featherbed Lane
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British101495410001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55231490005
    SMITH, Mark Robert
    Flat 36
    23 Hill Lane
    SO15 5PA Southampton
    Hampshire
    Director
    Flat 36
    23 Hill Lane
    SO15 5PA Southampton
    Hampshire
    British101494660001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Director designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Director designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    ¿Tiene CARE UK HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 jul 2010
    Entregado el 26 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 26 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deed of accession
    Creado el 09 dic 2004
    Entregado el 29 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from each company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for Itself and the Financeparties
    Transacciones
    • 29 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0