EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04426554 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PRIZEFOCAL LIMITED | 29 abr 2002 | 29 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 35 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Cameron Hannah Mclure como director el 31 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 37 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Steve Marc Prior el 10 may 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 08 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Albany Secretariat Limited como secretario el 20 jul 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Ailison Louise Mitchell como secretario el 20 jul 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Martin Timothy Smith como director el 01 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Leslie Tennant como director el 30 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 13 mar 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Frank David Laing como director el 14 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Karen Marie Hill como director el 14 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 37 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 03 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | Charlotte Street M1 4HB Manchester 3-5 England |
| 303585870001 | ||||||||||
| DONN, Michael Andrew | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 108352120001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| MCLURE, Cameron Hannah | Director | c/o Abrdn George Street EH2 2LL Edinburgh 1 Scotland | Scotland | British | 331818510001 | |||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 190982570023 | |||||||||
| PRIOR, Steven Marc | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 225624930002 | |||||||||
| SOLLEY, Christopher Thomas | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | 166666620001 | |||||||||
| MITCHELL, Ailison Louise | Secretario | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | British | 53150080001 | ||||||||||
| MOSS, James Henry | Secretario | 28a Somerfield Road N4 2JJ London | British | 79742730001 | ||||||||||
| HLM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 1st Floor 25 Stamford Street WA14 1EX Altrincham Cheshire | 118686920001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Director | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||||||
| ASHBROOK, Philip Peter | Director | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 121252960001 | |||||||||
| BRADLEY, Victoria Louise | Director | 26 Fitzgerald Avenue SW14 8SZ London | United Kingdom | British | 126733230001 | |||||||||
| BRUNNING, Charlotte Louise | Director | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 242374880001 | |||||||||
| CAMP, David John | Director | 236 St Magaret's Road TW1 1NL Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 4807190003 | |||||||||
| CAVE, David Anthony | Director | Flat 4 135 Breakspears Road SE4 1TY Brockley London | British | 82164230001 | ||||||||||
| DAVIS, Michael Edward | Director | Guy Lane CH3 7RZ Waverton Stapleford House Chester | United Kingdom | British | 131261410001 | |||||||||
| DICKIE, Timothy John | Director | 51 Summerside Place EH6 4NY Edinburgh | British | 107164130002 | ||||||||||
| DONN, Michael Andrew | Director | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | Scotland | British | 184269980001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GORMAN, Derek Robert | Director | 22 Sealstrand Dalgety Bay KY11 9NG Dunfermline Fife | British | 65470990001 | ||||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Director | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 206362380001 | |||||||||
| HEANEY, William Alexander | Director | Clematis Cottage 14 Deanway HP8 4JH Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 2538150001 | |||||||||
| HILL, Karen Marie | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 193296740001 | |||||||||
| HOCKADAY, Stephen | Director | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | 101894100001 | |||||||||
| HOILE, Richard David | Director | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 173473310001 | |||||||||
| JACKSON, Gregor Scott | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 191227420001 | |||||||||
| LEWIS, Frederick Paul | Director | 24 Riddy Lane Bourn CB3 7SP Cambridge Cambridgeshire | England | British | 15107950001 | |||||||||
| LIPTON, Stuart Anthony, Sir | Director | 40 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | 2068540001 | |||||||||
| MATHESON, Craig Stephen | Director | 35 Rectory Road Walthamstow E17 3BG London | New Zealand | 96577080002 | ||||||||||
| MCDONAGH, John | Director | 7 Brocklebank Road SW18 3AP London | British | 94012300001 | ||||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | England | British | 156461120001 | |||||||||
| MOSS, James Henry | Director | 28a Somerfield Road N4 2JJ London | British | 79742730001 | ||||||||||
| MULLER, Andrew John | Director | Flat 4 7 Barkston Gardens Earls Court SW5 0ER London | Australian | 77022680001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Sidecar Llp | 03 sept 2016 | Churchill Place Canary Wharf E14 5HJ London 20 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Consolidated Investment Holdings Limited | 03 sept 2016 | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0