TULA GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTULA GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04433635
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TULA GROUP LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TULA GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o EY
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TULA GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPEED 9165 LIMITED08 may 200208 may 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TULA GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TULA GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Jayne Mary Worden como director el 11 dic 2019

    1 páginasTM01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 ene 2019

    10 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Radley, 3rd Floor Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW a C/O Ey 1 More London Place London SE1 2AF el 21 feb 2018

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 31 ene 2018

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 26 ene 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the capital redemption reserve 25/01/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2016

    15 páginasAA

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Roger Clive Best como director el 03 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gregory Pratt como secretario el 03 jun 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Naomi Halliday como director el 03 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas James Vance como director el 03 jun 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 feb 2016

    Estado de capital el 03 feb 2016

    • Capital: GBP 264,250
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2015

    10 páginasAA

    Nombramiento de Mr Justin Paul David Stead como director el 07 ene 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Xavier Marie Olivier Simonet como director el 08 may 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2014

    AA

    ¿Quiénes son los directivos de TULA GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    STEAD, Justin Paul David
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandAmerican204126530001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Secretario
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    British67243220003
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secretario
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    PRATT, Gregory
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Secretario
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    167192940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, Pelham Brian
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    Director
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish166398180001
    BEST, Roger Clive
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Director
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish114728210001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Director
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Director
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish67243220004
    CORLETT, Anthony John Darcy
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Director
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    United KingdomBritish37929030005
    ENEVOLDSON, Karl Thyge
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    Director
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    British87906250001
    GAEDE, Sven Willi Swithin
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Director
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish122640470001
    HALLIDAY, Naomi
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Director
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    United KingdomBritish184787710001
    HARDER, Lowell Judith
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    Director
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    UkAustralian26244220001
    LISTER, Ivan James
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    Director
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    United KingdomBritish67150960004
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    RODRIGUES, Selwyn Mario Pius
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    Director
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    British78514760004
    SIMONET, Xavier Marie Olivier
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Director
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandFrench184753700001
    VANCE, Nicholas James
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Director
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish184753710001
    WARNER, Alan Mark
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    Director
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    United KingdomBritish119324870001
    WORDEN, Jayne Mary
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish109333140001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TULA GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    06 abr 2016
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland & Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro5707910
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TULA GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 09 dic 2007
    Entregado el 18 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 1 site b brundell drive brinklow mi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Agent)
    Transacciones
    • 18 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 12 jul 2006
    Entregado el 01 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 10 jul 2006
    Entregado el 14 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re tula group LTD and numbered 2061452 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respectthereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 13 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 25 feb 2006
    Entregado el 09 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 1, site b, brundell drive, brinklow, milton keynes t/n BM296212. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 09 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 21 feb 2003
    Entregado el 11 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 11 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 feb 2003
    Entregado el 28 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alan Mark Warner, Malcolm Warner, Christopher Howell and Peter Myers
    Transacciones
    • 28 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 feb 2003
    Entregado el 28 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lowell Judith Harder
    Transacciones
    • 28 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TULA GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ene 2018Inicio de la liquidación
    12 feb 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Profesional
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Profesional
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0