CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED

CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCEDAR THANET PHASE 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04435931
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Frp Advisory Llp 2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARILLION RICHARDSON THANET PHASE 2 LIMITED08 jul 200308 jul 2003
    CHELVERTON GROUP (THANET) LIMITED10 may 200210 may 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 jul 2020

    10 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY United Kingdom a Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB el 29 jul 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 jul 2019

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 1

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name14 ene 2019

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 dic 2018

    RES15

    Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY el 20 dic 2018

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Carillion Cr Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 dic 2018

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Simon Paul Eastwood como director el 12 dic 2018

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Simon Paul Eastwood el 01 oct 2018

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Carillion Cr Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 11 sept 2018

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 10 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RICHARDSON, Lee Scott
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Director
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    United KingdomEnglish66581210001
    RICHARDSON, Martyn Ford
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Director
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    United KingdomEnglish66581140001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Secretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    HOWCROFT, Martyn Jonathan
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Secretario
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    British8333740002
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235181670001
    MANIN, Richard Raymond Emile
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    Secretario
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    British29741390003
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    CARTISSER, Matthew Grant
    Leighton Manor Farm
    Spode Lane
    TN8 7HN Cowden
    Kent
    Director
    Leighton Manor Farm
    Spode Lane
    TN8 7HN Cowden
    Kent
    United KingdomBritish82316750001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Director
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    EASTWOOD, Simon Paul
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35184590004
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Director
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    MANIN, Richard Raymond Emile
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    Director
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    United KingdomBritish29741390003
    MORGAN, Simon Bruce
    Netherhope House
    Netherhope Lane
    NP16 7JG Tidenham
    Gloucestershire
    Director
    Netherhope House
    Netherhope Lane
    NP16 7JG Tidenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish86142950001
    RICHARDSON, Donald Barrie
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Director
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    British44851070002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury, Warley
    100
    West Midlands
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury, Warley
    100
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3783015
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    100
    England
    06 abr 2016
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    100
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03833633
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security interest agreement
    Creado el 07 nov 2008
    Entregado el 26 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The original collateral, an instrument of transfer the original notice see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 26 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 07 nov 2008
    Entregado el 26 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 26 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 30 jun 2004
    Entregado el 15 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot no. A and b (part of plots 9 and 19) premises at land associated with wickes building supplies limited margate road broadstairs and 3 haine road broadstairs and land at the rear administrative area thanet kent t/no. Part K733066 and part K852142. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 02 abr 2004
    Adquirido el 25 jun 2004
    Entregado el 16 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 2004Registro de una adquisición (400)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge debenture
    Creado el 02 abr 2004
    Entregado el 10 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 dic 2003
    Adquirido el 25 jun 2004
    Entregado el 16 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 2004Registro de una adquisición (400)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 24 dic 2003
    Entregado el 10 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land associated with wickes building supplies limited, margate road, broadstairs, t/n K733066. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 jul 2019Inicio de la liquidación
    05 nov 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gerald Clifford Smith
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Profesional
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Arvindar Jit Singh
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Profesional
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0