CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04435931 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CARILLION RICHARDSON THANET PHASE 2 LIMITED | 08 jul 2003 | 08 jul 2003 |
| CHELVERTON GROUP (THANET) LIMITED | 10 may 2002 | 10 may 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 jul 2020 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY United Kingdom a Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB el 29 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY el 20 dic 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Carillion Cr Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 dic 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Paul Eastwood como director el 12 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Paul Eastwood el 01 oct 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Carillion Cr Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 11 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDSON, Lee Scott | Director | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | United Kingdom | English | 66581210001 | |||||
| RICHARDSON, Martyn Ford | Director | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | United Kingdom | English | 66581140001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Secretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| HOWCROFT, Martyn Jonathan | Secretario | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | British | 8333740002 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235181670001 | |||||||
| MANIN, Richard Raymond Emile | Secretario | 236 Sheen Lane East Sheen SW14 8RL London | British | 29741390003 | ||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| CARTISSER, Matthew Grant | Director | Leighton Manor Farm Spode Lane TN8 7HN Cowden Kent | United Kingdom | British | 82316750001 | |||||
| COLLETT, Brian | Director | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| EASTWOOD, Simon Paul | Director | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | 35184590004 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Director | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| MANIN, Richard Raymond Emile | Director | 236 Sheen Lane East Sheen SW14 8RL London | United Kingdom | British | 29741390003 | |||||
| MORGAN, Simon Bruce | Director | Netherhope House Netherhope Lane NP16 7JG Tidenham Gloucestershire | England | British | 86142950001 | |||||
| RICHARDSON, Donald Barrie | Director | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | British | 44851070002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Cr Limited | 06 abr 2016 | Dudley Road East B69 3DY Oldbury, Warley 100 West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Foxborough Developments Limited | 06 abr 2016 | Dudley Road East B69 3DY Oldbury 100 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security interest agreement | Creado el 07 nov 2008 Entregado el 26 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The original collateral, an instrument of transfer the original notice see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 07 nov 2008 Entregado el 26 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage deed | Creado el 30 jun 2004 Entregado el 15 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Plot no. A and b (part of plots 9 and 19) premises at land associated with wickes building supplies limited margate road broadstairs and 3 haine road broadstairs and land at the rear administrative area thanet kent t/no. Part K733066 and part K852142. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 abr 2004 Adquirido el 25 jun 2004 Entregado el 16 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge debenture | Creado el 02 abr 2004 Entregado el 10 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 24 dic 2003 Adquirido el 25 jun 2004 Entregado el 16 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 24 dic 2003 Entregado el 10 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land associated with wickes building supplies limited, margate road, broadstairs, t/n K733066. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0