PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04439612 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOMBARD CORPORATE FINANCE (8) LIMITED | 15 may 2002 | 15 may 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2021 | 16 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Keith Damian Pereira el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Simon Charles Lowe el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2020 | 16 páginas | AA | ||
Nombramiento de Natwest Markets Secretarial Services Limited como secretario el 29 abr 2021 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Natwest Group Secretarial Services Limited como secretario el 29 abr 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del secretario Rbs Secretarial Services Limited el 16 sept 2020 | 1 páginas | CH04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2019 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2018 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Lombard Corporate Finance (11) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 jul 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Royal Bank Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jul 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mr Simon Charles Lowe como director el 26 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Paul Nixon como director el 26 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Quadrangle the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1PX a 250 Bishopsgate London London EC2M 4AA el 12 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Ian Andrew Ellis como director el 08 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Keith Damian Pereira como director el 08 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Stephen Paul Nixon como director el 08 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 239981580001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Secretario | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | British | 35994320001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Secretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Secretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Secretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Director | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Director | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Director | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 35994320001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Director | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CROME, Trevor Douglas | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 186705800001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Director | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| ELLIS, Ian Andrew | Director | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 243996550001 | |||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Director | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 74834980002 | |||||||||
| HARRIS, David Gerald | Director | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 236842580001 | |||||||||
| JOHNSON, Alan Piers | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 155895050001 | |||||||||
| LATTER, William Vaughan | Director | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| MAYES, Emma-Marie | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 258397370001 | |||||||||
| MCDAID, Neil Jason | Director | EC2M 4RB London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 222279310001 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PAYNE, Brian John | Director | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 38688940001 | |||||||||
| PEARCE, Nigel | Director | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| ROGERS, Julian Edwin | Director | 2 The Green RM15 6SD South Ockendon Nubbock House Essex England | England | British | 137180040001 | |||||||||
| ROULSTON, Steven James | Director | Ground Floor, Business House F EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn, PO BOX 1000 Scotland | Scotland | British | 238205130001 | |||||||||
| SHEPHARD, Ian Maxwell | Director | Hungerford House Pale Lane Winchfield RG27 8SW Hook Hampshire | British | 111421920002 | ||||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Director | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Christopher Paul | Director | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey | United Kingdom | British | 67033830004 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Director | 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedforedshire | England | British | 111421900001 | |||||||||
| TUBB, Philip Anthony | Director | 15 Mardleybury Road SG3 6SG Datchworth Hertfordshire | British | 98115740001 | ||||||||||
| WARREN, Roy Francis | Director | Glanville Drive Hinton Blewett BS39 5GF Bristol 4 Avon | England | British | 132967870001 | |||||||||
| WOOD, John Hamer | Director | Smith House, Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Rbs Invoice Finance | United Kingdom | British | 136006840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombard Corporate Finance (11) Limited | 11 jul 2017 | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Royal Bank Leasing Limited | 06 abr 2016 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PATALEX V PRODUCTIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of security assignment and charge | Creado el 08 oct 2004 Entregado el 21 oct 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right, title and interest in the entire copyright and all other rights in and to the picture being "derailed", all elements and any music, music compositions and recordings including lyrics, all contracts, the distribution agreement and book debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of security assignment and charge | Creado el 08 oct 2004 Entregado el 21 oct 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The entire copyright and all of the chargor's other rights in and to the picture being "derailed" and all elements contained therein and any music, music compositions and/or recordings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0