HOMEFLAG LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOMEFLAG LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04439855
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOMEFLAG LIMITED?

    • Operación de taxis (49320) / Transporte y almacenamiento
    • Otros transportes terrestres de pasajeros (49390) / Transporte y almacenamiento
    • Transportistas con licencia (53201) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra HOMEFLAG LIMITED?

    Dirección de la sede social
    35-37 William Road
    NW1 3ER London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOMEFLAG LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BLUEBACK LIMITED16 abr 200316 abr 2003
    VERYNOON LIMITED15 may 200215 may 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOMEFLAG LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOMEFLAG LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2016

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr David George Stickland como director el 01 jul 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 ago 2016

    Estado de capital el 09 ago 2016

    • Capital: GBP 2,023.81
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2015

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Boland como secretario el 04 ene 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Lee Gage como secretario el 04 ene 2016

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Andrew Kenneth Boland como secretario el 24 ago 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Gary Cust como secretario el 24 ago 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Gary Cust como director el 24 ago 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jul 2015

    Estado de capital el 03 jul 2015

    • Capital: GBP 2,023.81
    SH01

    Nombramiento de Chief Financial Officer Andrew Kenneth Boland como director el 03 mar 2015

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2014

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mr Gary Cust como director el 28 nov 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthew James Barbrook como director el 28 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Matthew James Barbrook como secretario el 25 abr 2014

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 may 2014

    Estado de capital el 20 may 2014

    • Capital: GBP 2,023.81
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2013

    3 páginasAA

    Nombramiento de Mr Gary Cust como secretario

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Resoluciones

    Resolutions
    29 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Cambio de datos del director Mr Liam Griffin el 17 may 2013

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de HOMEFLAG LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GAGE, Lee
    9 Boyd Street
    E1 1NH London
    Flat 9 Victoria Mills
    United Kingdom
    Secretario
    9 Boyd Street
    E1 1NH London
    Flat 9 Victoria Mills
    United Kingdom
    207449740001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    Director
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    United KingdomBritish71264540006
    GRIFFIN, Liam
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Director
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    EnglandBritish146320180001
    STICKLAND, David George
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    United Kingdom
    Director
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    United Kingdom
    United KingdomBritish130704670001
    BARBROOK, Matthew James
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Secretario
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    British79274880001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    Secretario
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    200421510001
    CUST, Gary
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Secretario
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    187183860001
    FOSTER, Daryl
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    Secretario
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    British43291390002
    KERR, Darren Mark, Mr.
    Christchurch Crescent
    WD7 8AU Radlett
    20a
    Hertfordshire
    Secretario
    Christchurch Crescent
    WD7 8AU Radlett
    20a
    Hertfordshire
    British140334370001
    PIELSTICKER, Charles Albert
    18 Hillhurst Blvd
    M4R 1K4 Toronto
    Ontario
    Canada
    Secretario
    18 Hillhurst Blvd
    M4R 1K4 Toronto
    Ontario
    Canada
    British82639410001
    PIELSTICKER, Scott William
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Secretario
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Canadian82639190003
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secretario designado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    DORSEYLAW SECRETARIES LIMITED
    21 Wilson Street
    EC2M 2TD London
    Secretario corporativo
    21 Wilson Street
    EC2M 2TD London
    74615640001
    BAILLIE, Aubrey
    90 St. Leonards Ave.
    Toronto
    Ontario M4n 1k5
    Director
    90 St. Leonards Ave.
    Toronto
    Ontario M4n 1k5
    Canadian109409880001
    BANKS, Joseph Robert
    2 Albert Place
    W8 5PD London
    Director
    2 Albert Place
    W8 5PD London
    United KingdomAmerican97950200001
    BARBROOK, Matthew James
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Director
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    United KingdomBritish79274880001
    BUTCHER, Nicholas Terence
    Moorcroft Abinger Lane
    Abinger Common
    RH5 6HZ Dorking
    Surrey
    Director
    Moorcroft Abinger Lane
    Abinger Common
    RH5 6HZ Dorking
    Surrey
    EnglandBritish18037300001
    CUST, Gary William
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    Director
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    EnglandBritish193071220001
    DARLING, Peter John
    Chandlers House
    Fenwick Place
    SW9 9NW London
    Director
    Chandlers House
    Fenwick Place
    SW9 9NW London
    British91106210001
    FOSTER, Daryl
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    United Kingdom
    Director
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    United Kingdom
    United KingdomBritish43291390003
    GRIFFIN, John Patrick
    23 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    23 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish,Irish43291450001
    GRIFFIN, Kieran
    Bedwell Park, Cucumber Lane
    Essendon
    AL9 6GJ Hatfield
    Pulham House
    Hertfordshire
    Director
    Bedwell Park, Cucumber Lane
    Essendon
    AL9 6GJ Hatfield
    Pulham House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish82674390003
    JOHNSON, Donald Kenneth
    287 Oriole Parkway
    MSP 2H4 Toronto
    Ontario Ms9 2h4
    Canada
    Director
    287 Oriole Parkway
    MSP 2H4 Toronto
    Ontario Ms9 2h4
    Canada
    Canadian109607400001
    KENNEDY, Andrew James
    2 Edgarley Terrace
    SW6 6QF London
    Director
    2 Edgarley Terrace
    SW6 6QF London
    United KingdomCanadian101185570001
    L'HEUREUX, Willard John
    Eotvos U 47
    FOREIGN Budapest
    1067
    Hungary
    Director
    Eotvos U 47
    FOREIGN Budapest
    1067
    Hungary
    Canadian91989750001
    PEARCE, Colin Leighton
    Lamorna 38 Denham Lane
    SL9 0ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    Lamorna 38 Denham Lane
    SL9 0ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish169666820001
    PIELSTICKER, Scott William
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Director
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Canadian82639190003
    SCHWARZ, Steve
    12 Measham Road
    LE65 2PF Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Director
    12 Measham Road
    LE65 2PF Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    EnglandBritish109410140001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Director designado
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    HELKON SK LIMITED
    74a Charlotte Street
    W1T 4QJ London
    Director corporativo
    74a Charlotte Street
    W1T 4QJ London
    91989880001

    ¿Tiene HOMEFLAG LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture without written instrument
    Creado el 02 may 2007
    Entregado el 22 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £300,000.00 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    All company assets.
    Personas con derecho
    • A. Baillie - Vyco LTD
    Transacciones
    • 22 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 ene 2007
    Entregado el 07 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £300,000 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over all assets of the company.
    Personas con derecho
    • A Baillie, Vyco LTD
    Transacciones
    • 07 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 nov 2006
    Entregado el 29 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000 due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • A Baillie Vyco LTD Bmc Capital for Details of Further Chargees Please Refer to Form 395
    Transacciones
    • 29 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 jun 2006
    Entregado el 26 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £500,000 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    Fixed charge over the chattels and equipment, book debts, goodwill and uncalled capital and floating charge, all the undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ausnoram Holdings, a Baillie, Pf Little for Further Names of the Mortgages or Persons Entitledto the Charge Please Refer to the Form 395
    Transacciones
    • 26 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture without written instrument
    Creado el 23 nov 2005
    Entregado el 07 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,542,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts).
    Personas con derecho
    • Scott Pielsticker, Ausnoram Holdings, a Baillie for Further Details of Names of the Mortgageesor Persons Entitled Please Refer to the Form 395
    Transacciones
    • 07 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture without written instrument
    Creado el 22 nov 2005
    Entregado el 02 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £40,000 and us$80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts).
    Personas con derecho
    • Mr J Konken and Mr C Webster
    Transacciones
    • 02 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 29 jun 2004
    Entregado el 05 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 05 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 nov 2003
    Entregado el 19 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0