LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04440067 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 16 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 17 páginas | AA | ||||||
Cambio de datos del director Keith Damian Pereira el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Charles Lowe el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 18 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 18 páginas | AA | ||||||
Segunda presentación para la terminación de David Gerald Harris como director | 5 páginas | RP04TM01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Notification de Lombard Corporate Finance (11) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 jul 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||
Cessation de Royal Bank Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jul 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Nombramiento de Mr Simon Charles Lowe como director el 26 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Stephen Paul Nixon como director el 26 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Quadrangle the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1PX a 250 Bishopsgate London London EC2M 4AA el 12 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||
Cese del nombramiento de Ian Andrew Ellis como director el 08 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Nombramiento de Keith Damian Pereira como director el 08 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Stephen Paul Nixon como director el 08 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Steven James Roulston como director el 08 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de David Gerald Harris como director el 08 ene 2018 | 2 páginas | TM01 | ||||||
| ||||||||
Nombramiento de Natwest Markets Secretarial Services Limited como secretario el 26 nov 2018 | 2 páginas | AP04 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 239981580001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Secretario | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | British | 35994320001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Secretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Secretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Secretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Director | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Director | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Director | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 35994320001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Director | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CROME, Trevor Douglas | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 186705800001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Director | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| ELLIS, Ian Andrew | Director | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 243996550001 | |||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Director | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 74834980002 | |||||||||
| HARRIS, David Gerald | Director | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 236842580001 | |||||||||
| JOHNSON, Alan Piers | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 155895050001 | |||||||||
| LATTER, William Vaughan | Director | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| MAYES, Emma-Marie | Director | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 258397370001 | |||||||||
| MCDAID, Neil Jason | Director | EC2M 4RB London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 222279310001 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PAYNE, Brian John | Director | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 38688940001 | |||||||||
| PEARCE, Nigel | Director | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| ROGERS, Julian Edwin | Director | 2 The Green RM15 6SD South Ockendon Nubbock House Essex England | England | British | 137180040001 | |||||||||
| ROULSTON, Steven James | Director | Ground Floor, Business House F EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn, PO BOX 1000 Scotland | Scotland | British | 238205130001 | |||||||||
| SHEPHARD, Ian Maxwell | Director | Hungerford House Pale Lane Winchfield RG27 8SW Hook Hampshire | British | 111421920002 | ||||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Director | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Christopher Paul | Director | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey | United Kingdom | British | 67033830004 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Director | 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedforedshire | England | British | 111421900001 | |||||||||
| TUBB, Philip Anthony | Director | 15 Mardleybury Road SG3 6SG Datchworth Hertfordshire | British | 98115740001 | ||||||||||
| WARREN, Roy Francis | Director | Glanville Drive Hinton Blewett BS39 5GF Bristol 4 Avon | England | British | 132967870001 | |||||||||
| WOOD, John Hamer | Director | Smith House, Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Rbs Invoice Finance | United Kingdom | British | 136006840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LOMBARD CORPORATE FINANCE (7) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombard Corporate Finance (11) Limited | 11 jul 2017 | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Royal Bank Leasing Limited | 06 abr 2016 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0