MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 04440523 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
- Administración de la propiedad de los residentes (98000) / Actividades de los hogares como empleadores; actividades de producción de bienes y servicios no diferenciadas de los hogares para uso propio
¿Dónde se encuentra MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Zenith Management, Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2025 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2024 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Mark Anthony Slevin como director el 31 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Matthew Sean Kennedy como director el 03 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Zenith Management Limited el 11 jun 2024 | 1 páginas | CH04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Nq Building 47 Bengal Street Manchester M4 6BB England a C/O Zenith Management, Nq Building 47 Bengal Street Manchester M4 6BB el 19 mar 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2021 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 4 páginas | AA | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2019 | 4 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Mark Stephen Farrar como director el 13 ago 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Matthew Sean Kennedy como director el 24 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Danny Cheshire como director el 17 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de James Christopher Darcey como director el 01 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Zenith Management Ltd como secretario el 21 feb 2020 | 2 páginas | AP04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Revolution Property Management Ltd 384a Deansgate Manchester M3 4LA England a Nq Building 47 Bengal Street Manchester M4 6BB el 01 oct 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Revolution Property Management Ltd como secretario el 01 oct 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENITH MANAGEMENT LIMITED | Secretario corporativo | Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management England |
| 196285800002 | ||||||||||
| BAILEY, David Francis | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management, Nq Building England | England | British | 30569680001 | |||||||||
| FARRAR, Mark Stephen | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management, Nq Building England | England | British | 275051540001 | |||||||||
| HALLEY, Michael Francis | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management, Nq Building England | England | British | 186113890001 | |||||||||
| WIMBUSH, Paul | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management, Nq Building England | England | British | 221019270001 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 147317230001 | |||||||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 165977920001 | |||||||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Scotland Street Stoke By Nayland CO6 4QF Colchester Homestead Essex | Other | 135438270002 | ||||||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||||||
| RICHMOND, Sonia Anna | Secretario | 118 Weymede Byfleet KT14 7DJ West Byfleet Surrey | British | 81951800001 | ||||||||||
| STOTE, Tanya | Secretario | Honeyburge The Fordrough B90 1PP Solihull West Midlands | British | 113603590001 | ||||||||||
| REVOLUTION PROPERTY MANAGEMENT LTD | Secretario corporativo | Deansgate M3 4LA Manchester 384a England |
| 81434940002 | ||||||||||
| BROOKS, John Howard | Director | Arcadian Farnborough Hill BR6 7EQ Orpington Kent | United Kingdom | British | 34160470002 | |||||||||
| CHESHIRE, Danny | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester Nq Building England | England | British | 221812200001 | |||||||||
| CORDINGLEY, Emma Jane | Director | 14 Appleton Road Hale WA15 9LP Altrincham Cheshire | British | 81417420001 | ||||||||||
| CULLEN, Paul Desmond | Director | c/o Revolution Property Management Ltd Deansgate M3 4LA Manchester 384a England | England United Kingdom | British | 181917370001 | |||||||||
| DARCEY, James Christopher | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester Nq Building England | England | British | 188772040001 | |||||||||
| FURY, Beverly Anne | Director | Lumsdale Road Stretford M32 0UT Manchester 1 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 137551200001 | |||||||||
| HASSALL, Alison | Director | Lumsdale Road Stretford M32 0UT Manchester 1 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 127646920001 | |||||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Director | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | United Kingdom | British | 4733610001 | |||||||||
| JACOMB, Timothy Philip Bryan | Director | c/o Revolution Property Management Ltd Deansgate M3 4LA Manchester 384a England | England United Kingdom | British | 137367540001 | |||||||||
| KENNEDY, Matthew Sean | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management, Nq Building England | England | British | 271190140001 | |||||||||
| LOCKE, Andrew | Director | Granta Cottage Mill Lane CB2 4NE Wittlesford Cambridgeshire | British | 73999340001 | ||||||||||
| MAINWARING, Mark | Director | 7 Saxon Close Appleton WA4 5SD Warrington Cheshire | England | British | 192267860001 | |||||||||
| PARKER, Guy Trevor | Director | Cann Lane North Woodside Mews WA4 5NF Appleton Warrington Caxton House | England | British | 130108080001 | |||||||||
| PICKTHALL, Robert | Director | 174 Glazebrook Lane Glazebrook WA3 5AY Warrington Cheshire | British | 3227370001 | ||||||||||
| SADLER, Jonathan Antony | Director | c/o Revolution Property Management Ltd Deansgate M3 4LA Manchester 384a England | Uk | British | 141860240002 | |||||||||
| SEDDON, James | Director | c/o Revolution Property Management Ltd Deansgate M3 4LA Manchester 384a England | England United Kingdom | British | 181917470001 | |||||||||
| SLEVIN, Mark Anthony, Prof | Director | 47 Bengal Street M4 6BB Manchester C/O Zenith Management, Nq Building England | United Kingdom | British | 221905090001 | |||||||||
| VELLA, Peter Vincent | Director | 93 Britannia Mills 11 Hulme Hall Road, Castlefield M15 4LB Manchester | British | 98481510001 | ||||||||||
| WARD, Elizabeth Jane | Director | New Wakefield Street M1 5NP Manchester 29 The Green Building | England | British | 181564440001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para MACINTOSH VILLAGE (MANAGEMENT) LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 16 may 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0