LEGACY COMPANY SIX LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LEGACY COMPANY SIX LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04470423 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?
- Actividades de servicios de sistemas de seguridad (80200) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra LEGACY COMPANY SIX LIMITED?
Dirección de la sede social | 4th Floor Abbey House Booth Street M2 4AB Manchester |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
DETECTOR TECHNOLOGIES LIMITED | 18 feb 2003 | 18 feb 2003 |
HALLCO 789 LIMITED | 26 jun 2002 | 26 jun 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 15 abr 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEGACY COMPANY SIX LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Presentación de insolvencia Insolvency:sec state release of liq | 4 páginas | LIQ MISC | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 sept 2018 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU a 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB el 16 nov 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 15 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 sept 2017 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB England a 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU el 13 oct 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 15 abr 2017 au 30 jun 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 15 abr 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 2 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2016 au 15 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Newton como director el 09 jun 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Pauline Anne Norstrom como director el 18 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Newton como director el 19 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie como director el 17 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Pamela Doroszkiewicz como secretario el 17 abr 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS a No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB el 12 mar 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2015 au 31 dic 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Newton como director el 13 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWTON, Michael James | Director | Abbey House Booth Street M2 4AB Manchester 4th Floor | England | British | Director | 24712770003 | ||||
BENTLEY-BUCHANAN, Sarah | Secretario | Strines Road Strines SK6 7GA Stockport 180 Cheshire United Kingdom | British | 135492410001 | ||||||
DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela | Secretario | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | 161099500001 | |||||||
MCCOMBE, David Walter | Secretario | The Woodlands Westcott Street RH4 3NU Westcott Surrey | British | Company Secretary | 80583660001 | |||||
MOORE, Ian Frederick | Secretario | 8 Westland Drive PO7 5UG Waterlooville Hampshire | British | 75778420001 | ||||||
SHUTE, Richard Carl | Secretario | Apple Tree Cottage Preston Road MK18 4HS Gawcott Buckinghamshire | British | General Manager | 87650830001 | |||||
HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||
AIRD, Robert Frederick | Director | Pentlands Hookley Lane, Elstead GU8 6JB Godalming Surrey | British | Director | 61691910005 | |||||
FINN, Andrew Patrick | Director | Treetops 241 Bramhall Moor Road SK7 5JL Hazel Grove Stockport Cheshire | England | British | Director | 169499300001 | ||||
MOORE, Ian Frederick | Director | 8 Westland Drive PO7 5UG Waterlooville Hampshire | England | British | Manager | 75778420001 | ||||
MOORE, Ian Frederick | Director | 8 Westland Drive PO7 5UG Waterlooville Hampshire | England | British | Manager | 75778420001 | ||||
NEWTON, Michael James | Director | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | England | British | Director | 24712770003 | ||||
NEWTON, Michael James | Director | Frandley House Warrington Road Antrobus CW9 6HB Northwich Cheshire | British | Director | 84319290001 | |||||
NORSTROM, Pauline Anne | Director | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | England | British | Director | 148506110001 | ||||
PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh | Director | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | Wales | British | Director | 51578980004 | ||||
WISEBERG, Adam Harris | Director | Tollbar Cottage Chester Road Over Tabley WA16 0PR Knutsford Cheshire | England | British | Director | 141666340001 | ||||
HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013270001 |
¿Tiene LEGACY COMPANY SIX LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 18 oct 2011 Entregado el 22 oct 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 18 oct 2011 Entregado el 21 oct 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 04 may 2006 Entregado el 10 may 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The deposit of £5140.63 in an interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 25 jun 2003 Entregado el 02 jul 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene LEGACY COMPANY SIX LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0