LEGACY COMPANY SIX LIMITED

LEGACY COMPANY SIX LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLEGACY COMPANY SIX LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04470423
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    • Actividades de servicios de sistemas de seguridad (80200) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DETECTOR TECHNOLOGIES LIMITED18 feb 200318 feb 2003
    HALLCO 789 LIMITED26 jun 200226 jun 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta15 abr 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:sec state release of liq
    4 páginasLIQ MISC

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 sept 2018

    11 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU a 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB el 16 nov 2018

    2 páginasAD01

    Destitución del liquidador por orden judicial

    15 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 sept 2017

    10 páginasLIQ03

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB England a 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU el 13 oct 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 21 sept 2016

    LRESSP

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name26 ago 2016

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 ago 2016

    RES15

    Exercice comptable en cours raccourci du 15 abr 2017 au 30 jun 2016

    1 páginasAA01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 15 abr 2016

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    2 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 jun 2016

    Estado de capital el 14 jun 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2016 au 15 abr 2016

    1 páginasAA01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2015

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael James Newton como director el 09 jun 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Pauline Anne Norstrom como director el 18 abr 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael James Newton como director el 19 abr 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie como director el 17 abr 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Helen Pamela Doroszkiewicz como secretario el 17 abr 2016

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS a No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB el 12 mar 2016

    1 páginasAD01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2015 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Michael James Newton como director el 13 ene 2016

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NEWTON, Michael James
    Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    Director
    Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    EnglandBritishDirector24712770003
    BENTLEY-BUCHANAN, Sarah
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    British135492410001
    DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Secretario
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    161099500001
    MCCOMBE, David Walter
    The Woodlands
    Westcott Street
    RH4 3NU Westcott
    Surrey
    Secretario
    The Woodlands
    Westcott Street
    RH4 3NU Westcott
    Surrey
    BritishCompany Secretary80583660001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Secretario
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    British75778420001
    SHUTE, Richard Carl
    Apple Tree Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    Secretario
    Apple Tree Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager87650830001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Secretario designado corporativo
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    AIRD, Robert Frederick
    Pentlands
    Hookley Lane, Elstead
    GU8 6JB Godalming
    Surrey
    Director
    Pentlands
    Hookley Lane, Elstead
    GU8 6JB Godalming
    Surrey
    BritishDirector61691910005
    FINN, Andrew Patrick
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    Director
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector169499300001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Director
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishManager75778420001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Director
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishManager75778420001
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Director
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector24712770003
    NEWTON, Michael James
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    Director
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    BritishDirector84319290001
    NORSTROM, Pauline Anne
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Director
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector148506110001
    PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Director
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    WalesBritishDirector51578980004
    WISEBERG, Adam Harris
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    Director
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector141666340001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Director designado corporativo
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    ¿Tiene LEGACY COMPANY SIX LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 18 oct 2011
    Entregado el 22 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creado el 18 oct 2011
    Entregado el 21 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Michael James Newton
    Transacciones
    • 21 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 04 may 2006
    Entregado el 10 may 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit of £5140.63 in an interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Delta Developments (Alton) Limited
    Transacciones
    • 10 may 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 25 jun 2003
    Entregado el 02 jul 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jul 2003Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene LEGACY COMPANY SIX LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 sept 2016Inicio de la liquidación
    15 ago 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Russell Stewart Cash
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Profesional
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Profesional
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0