IOIM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IOIM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04480408 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IOIM LIMITED?
- Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra IOIM LIMITED?
| Dirección de la sede social | Grace House 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York North Yorkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IOIM LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IOIM LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 23 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IOIM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 mar 2025 | 7 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Diane Elizabeth Ward como director el 11 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Elisabetta Battistella como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Edward Mccormac como director el 29 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Christopher Walsh como director el 07 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Gary William Pine como director el 15 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Anthony O'donnell como director el 11 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Bruce Campbell Rayner como director el 07 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 mar 2024 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Diane Elizabeth Ward como director el 10 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Dr Stephen Edward Mccormac como director el 10 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Kevin John Briggs como director el 10 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mike Thompson como director el 30 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Pauline Maria Garnett como director el 14 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 mar 2023 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Dominic Lewis Mason como director el 17 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 mar 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas Francis Brass como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jacqui Rigby como director el 25 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Grace House 90 Main Street Upper Poppleton York YO26 6JU England a Grace House 90 Main Street Upper Poppleton York North Yorkshire YO26 6JU el 23 mar 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Dolphins Elmstead Road West Byfleet Weybridge Surrey KT14 6JB a Grace House 90 Main Street Upper Poppleton York North Yorkshire YO26 6JU el 23 mar 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de IOIM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUART, Charles | Secretario | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | 235851630001 | |||||||
| BATTISTELLA, Elisabetta | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | Italy | Italian | 337880290001 | |||||
| BRIGGS, Kevin John | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | England | British | 330230180001 | |||||
| EVANS, Ralph Anthony | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | United Kingdom | British | 98567870001 | |||||
| O'DONNELL, Anthony | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | United Kingdom | British | 333643700001 | |||||
| PINE, Gary William | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | England | British | 78739580001 | |||||
| STUART, Charles | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | England | British | 103939010004 | |||||
| BRASS, Thomas Francis | Secretario | Dolphins, Elmstead Road KT14 6JB West Byfleet Surrey | British | 51577420001 | ||||||
| PUGH, David John | Secretario | 15 Partridge Way Merrow Park GU4 7DW Guildford Surrey | British | 226027380001 | ||||||
| SALLONS, Jacob Louis Christian | Secretario | 19 Foxcote Finchampstead RG11 3PG Wokingham Berkshire | British | 28005900001 | ||||||
| WHALLEY, Andrew James | Secretario | 62 Milward Road TN34 3RR Hastings East Sussex | British | 65102280002 | ||||||
| WILLIAMS, Kelvin | Secretario | 7 Park Road RH8 0AL Oxted Surrey | British | 79672690001 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Secretario designado corporativo | 39a Leicester Road M7 4AS Salford | 900014920001 | |||||||
| ACCAD, Nimr | Director | Crofton Close SO17 1XB Southampton 6 England | England | British,Australian | 269158460001 | |||||
| AYOUB, Mohamed, Mr. | Director | Bushey Road SW20 0JN London 123 England United Kingdom | England | British | 102709790001 | |||||
| BARKER, Tony | Director | Dolphins Elmstead Road West Byfleet KT14 6JB Weybridge Surrey | England | British | 135338000001 | |||||
| BRASS, Thomas Francis | Director | Dolphins, Elmstead Road KT14 6JB West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51577420001 | |||||
| CARGILL, Gail | Director | 2 Sherenden Park Golden Green TN11 0LQ Tonbridge Kent | British | 102212570001 | ||||||
| CHAMBERS, Robert Michael | Director | 9 St Saviours Wharf Mill Street SE1 2BE London | England | English | 98346470001 | |||||
| DORCHESTER, Martin | Director | 7 Derwent Close DA1 2TT Dartford Kent | British | 102175690001 | ||||||
| ELEY, Martin | Director | 45 Cyress Avenue AL7 1HN Welwyn Garden City Hertfordshire | United Kingdom | British | 106492470001 | |||||
| GARNETT, Pauline Maria | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | England | British | 168732190002 | |||||
| GRAHAM- WEALL, Stephen | Director | 4 Glenthorne Close GL10 2EF Stonehouse Gloucestershire | United Kingdom | British | 107438950002 | |||||
| GREEN, Michael | Director | 4 Potterton Close Barwick In Elmet LS15 4DY Leeds West Yorkshire | England | British | 9581830001 | |||||
| HOLLIMAN, Geoffrey Thomas Roland | Director | 28 Queen Street G84 9QL Helensburgh Dunbartonshire | British | 56194370001 | ||||||
| HUSBANDS, Hilary Anne Elizabeth Fitzgerald | Director | Conygree Close Lower Earley RG6 4XE Reading 11 Berkshire United Kingdom | England | British | 120240540003 | |||||
| IENT, Victor Sidney | Director | Field House 11 Mushroom Field Kingston BN7 3LE Lewes East Sussex | British | 82101400001 | ||||||
| JONES, Simon Clive | Director | Dolphins Elmstead Road West Byfleet KT14 6JB Weybridge Surrey | England | British | 304951040001 | |||||
| JONES, Simon Clive | Director | Perrott Close North Leigh OX29 6RV Witney 29 Oxfordshire United Kingdom | England | British | 57787610005 | |||||
| MASON, Dominic Lewis | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | England | British | 202500280001 | |||||
| MCCORMAC, Stephen Edward, Dr | Director | 90 Main Street Upper Poppleton YO26 6JU York Grace House North Yorkshire England | England | Irish | 228223090004 | |||||
| MCCORMACK, Ettie | Director | Barton Road Water Eaton MK2 3HW Milton Keynes Suite 428, 39a Buckinghamshire | United Kingdom | British | 135899020001 | |||||
| MITCHELL, David | Director | Balgray 66 Williams Way WD7 7HB Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 92280130001 | |||||
| MOECKELL, Judith Isabel | Director | 85 Plough Road Battersea SW11 2BJ London | United Kingdom | British | 125855620001 | |||||
| MUNRO, Andrew David | Director | Ivar Gardens Lychpit RG24 8YD Basingstoke 67 Hampshire | United Kingdom | British | 39441830002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IOIM LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institute Of Interim Management | 09 jul 2016 | Elmstead Road KT14 6JB West Byfleet Dolphins Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0