WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED

WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWESTERN WINES HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04485988
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Thomas Hardy House
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Surrey
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HAMSARD 2545 LIMITED27 ago 200227 ago 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2024
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta15 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence29 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta15 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2023

    22 páginasAA

    legacy

    111 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Cambio de datos del director Mr Derek William Nicol el 26 feb 2024

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Derek William Nicol como director el 15 feb 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Caroline Thompson-Hill como director el 15 feb 2024

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Tejvir Singh el 31 ago 2023

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2022

    20 páginasAA

    legacy

    103 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cambio de datos del director Ms Caroline Thompson-Hill el 23 ago 2022

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Catherine Judith Shrimplin como director el 24 ago 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2021

    21 páginasAA

    legacy

    103 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cambio de datos del director Ms Caroline Thompson-Hill el 14 oct 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Tejvir Singh el 20 oct 2021

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Alastair David James Snook como director el 29 jul 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Catherine Judith Shrimplin como director el 29 jul 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SINGH, Tejvir
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    256551660001
    NICOL, Derek William
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector262168800017
    SINGH, Tejvir
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianCompany Director256551570014
    CLOTHIER, Esther
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    162194340001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    BritishCompany Secretary28396500005
    GLENNIE, Helen Margaret
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Secretario
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    149220150001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    157430910002
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Secretario
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    BritishSolicitor69554640002
    RYAN, Julie Anne
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    209633630001
    SPENCER, Nicola Jane
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    180939140001
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    161850700001
    WOOD, Anthony Graham
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    248241710001
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    HSE SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretario designado corporativo
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    900023720001
    BAMBERGER, Jonathan
    63 Admiral Road
    Toronto
    Ontario M5r 2lr
    Canada
    Director
    63 Admiral Road
    Toronto
    Ontario M5r 2lr
    Canada
    CanadaBritishExecutive Vp189830120001
    BROCKETT, Gavin Stuart
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaSouth AfricanAccountant167554030002
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmericanDirector130789730003
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Director
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritishCompany Secretary28396500005
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Director
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant157727790001
    EAST, Michael Joseph
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianCompany Director179426220001
    GABB, Roger Michael
    Woodlands Hall
    Glazeley
    WV16 6AB Bridgnorth
    Salop
    Director
    Woodlands Hall
    Glazeley
    WV16 6AB Bridgnorth
    Salop
    EnglandBritishWine & Spirit Merchant141310320001
    GLENNIE, Helen Margaret
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Director
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director137615160001
    GORST, Steven Lee
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    CanadaCanadianCompany Director180938750002
    HETTERICH, Francis Paul
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmericanCompany Director147054340001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianAccountant157415150002
    JONES, Richard
    58 Braeside Road
    Toronto
    Ontario M4n 1x7
    Canada
    Director
    58 Braeside Road
    Toronto
    Ontario M4n 1x7
    Canada
    CanadianExecutive Vice President Finan96543150001
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Director
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    AmericanDirector119928070001
    LEWIS, Alan Stuart
    Farleigh Road
    Backwell
    BS48 3PE Bristol
    Southfield Farm
    North Somerset
    United Kingdom
    Director
    Farleigh Road
    Backwell
    BS48 3PE Bristol
    Southfield Farm
    North Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector139548580001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Director
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor69554640002
    MCKEON, Adrian Francis
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director, Ukir123271770001
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Director
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    AmericanCompany Director114902210001
    PAUL, Michael Anthony Keyes
    Upper Cound House
    SY5 6AX Cound
    Salop
    Director
    Upper Cound House
    SY5 6AX Cound
    Salop
    United KingdomBritishWine Importer106529070001
    RATCLIFFE, Robert John
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishManagement Consultant185752460001
    RYAN, Julie Anne
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianSolicitor230311770001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Accolade Wines Europe No. 2 Limited
    Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    England
    06 abr 2016
    Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroUk Register Of Companies
    Número de registro2715046
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 oct 2016
    Entregado el 31 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as New UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 01 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 14 oct 2016
    Entregado el 21 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 01 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 18 oct 2011
    Entregado el 25 oct 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited (As UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 01 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage of shares
    Creado el 30 mar 2005
    Entregado el 18 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the bank facility agent, the collateral agent or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the shares and the interest in all shares, stocks, debentures, bonds, warrants, coupons or other securities and investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia as the Collateral Agent Under the Intercreditor Agreement for Thebenefited Parties
    Transacciones
    • 18 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of paul letheren
    Creado el 09 oct 2002
    Entregado el 14 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of stephen smith
    Creado el 09 oct 2002
    Entregado el 14 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of anthony fairbank
    Creado el 09 oct 2002
    Entregado el 14 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of jon woodriffe
    Creado el 09 oct 2002
    Entregado el 14 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of michael paul
    Creado el 09 oct 2002
    Entregado el 14 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture ("composite debenture")
    Creado el 20 sept 2002
    Entregado el 27 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transacciones
    • 27 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 sept 2002
    Entregado el 30 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transacciones
    • 30 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0