ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED

ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04500265
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED?

    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FBW PROPERTIES (NO 1) LIMITED31 jul 200231 jul 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cese del nombramiento de Paul Clarke como secretario el 15 sept 2013

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Paul Clarke como director el 15 sept 2013

    2 páginasTM01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Aviso de finalización automática de la administración

    12 páginas2.30B

    Informe de progreso del administrador hasta 13 ene 2012

    13 páginas2.24B

    Declaración de la propuesta del administrador

    18 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de 32 Queen Anne Street London W1G 8HD England el 02 ago 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 ago 2010

    Estado de capital el 16 ago 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Denise Price el 27 jul 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Charles Price el 27 jul 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Kevin Fawcett el 27 jul 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Paul Clarke el 27 jul 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Paul Clarke el 27 jul 2010

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 48 George Street London W1U 7DY el 22 jul 2010

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    14 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FAWCETT, Kevin
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishDevelopment Director64098840002
    PRICE, Charles Ian
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishProperty Company Director147868510001
    PRICE, Denise
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishDesigner18800710006
    CLARKE, Paul
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Secretario
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    BritishFinance Director147868760001
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    British103719400001
    MCCALL, Rebecca Jane
    52 Rock Lane
    LS13 1DX Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    52 Rock Lane
    LS13 1DX Leeds
    West Yorkshire
    British80214480001
    PRICE, Denise
    1 Furze Field
    KT22 0UR Oxshott
    Surrey
    Secretario
    1 Furze Field
    KT22 0UR Oxshott
    Surrey
    British18800710004
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South AfricanFinancial Director40527920003
    WHITELEGG, James
    6 Grange View
    Colton View
    LS15 9LD Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    6 Grange View
    Colton View
    LS15 9LD Leeds
    West Yorkshire
    British98023070001
    CLARKE, Paul
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishFinance Director147868760001
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Director
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant103719400001
    HAMER, John James Arthur
    Norwood Barn Carlton Lane
    LS19 7BG East Carlton
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Norwood Barn Carlton Lane
    LS19 7BG East Carlton
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor83439730001
    HEALEY, Jonathan Andrew
    7 Dickinson Street
    Horsforth
    LS18 5AG Leeds
    West Yorkshire
    Ls18 5ag
    Director
    7 Dickinson Street
    Horsforth
    LS18 5AG Leeds
    West Yorkshire
    Ls18 5ag
    BritishSolicitor96169490001
    MOORE, Cornus
    Im Eichli 9
    6315 Oberageri
    Zug Canton 6315
    Switzerland
    Director
    Im Eichli 9
    6315 Oberageri
    Zug Canton 6315
    Switzerland
    SwitzerlandSouth AfricanBusinessman87997470001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South AfricanFinancial Director40527920003
    STASSEN, Carel
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    Director
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    South AfricanManaging Director104942950001

    ¿Tiene ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 29 mar 2005
    Entregado el 05 abr 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 05 abr 2005Registro de un cargo (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 18 april 2005 on
    Creado el 22 mar 2005
    Entregado el 22 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All and whole those shop premises at 320, 322, 324, 328, 330 and 332 argyle street glasgow t/n GLA72508.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 22 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 oct 2003
    Entregado el 05 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets, book debts & other debts, stocks shares and/or other securities, goodwill and all other intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transacciones
    • 05 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite share charge and guarantee and indemnity
    Creado el 24 oct 2003
    Entregado el 04 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and yms properties (no. 2) limited and ps properties (no. 2) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the securities and their proceeds of sale; all dividends, interest and other distributions. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 04 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)

    ¿Tiene ARGYLE STREET PROPERTIES (NO 1) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 jul 2011Inicio de la administración
    13 jul 2012Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Profesional
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Profesional
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0