RENANTIS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RENANTIS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04501104 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RENANTIS UK LIMITED?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RENANTIS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Third Floor 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RENANTIS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FALCK RENEWABLES WIND LIMITED | 03 mar 2011 | 03 mar 2011 |
| FALCK RENEWABLES WIND PLC | 03 mar 2011 | 03 mar 2011 |
| FALCK RENEWABLES PLC | 21 dic 2007 | 21 dic 2007 |
| FALCK RENEWABLES LIMITED | 01 ago 2002 | 01 ago 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RENANTIS UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RENANTIS UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RENANTIS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Notification de Nadara Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 ene 2024 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Kevin Mccullough en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Henry Fayne en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 ene 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Clarence O'neill Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 ene 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Ms Sarah Elizabeth Black como director el 03 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Notification de Kevin Mccullough en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2026 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Michael Nagle en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de David Picton-Turbervill como director el 20 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Carmelo Scalone como director el 20 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Finley Sean Becks-Phelps como director el 20 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | 34 páginas | AA | ||
legacy | 142 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr David Picton-Turbervill como director el 09 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Carmelo Scalone como director el 09 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Picton-Turbervill como director el 09 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Anna Graham Cameron como director el 03 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Patrick Paul Adam como director el 30 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Stewart Dibley como director el 24 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 38 páginas | AA | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP England a Third Floor 10 Lower Grosvenor Place London SW1W 0EN | 1 páginas | AD02 | ||
Cessation de Vumindaba Dube en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 ene 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
¿Quiénes son los directivos de RENANTIS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKS-PHELPS, Finley Sean | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Scotland | British | 267668380002 | |||||||||
| BLACK, Sarah Elizabeth | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Scotland | British | 323802070001 | |||||||||
| CAMERON, Anna Graham | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Scotland | British | 323798230001 | |||||||||
| HUNTER, Erin Lynn Murchie | Secretario | Brighton Place AB10 6RS Aberdeen 16 Scotland | British | 105387640015 | ||||||||||
| SINATRA, Carlo | Secretario | Via Manzoni 8/Bis 20052 Monza Milan Italy | British | 90018310001 | ||||||||||
| CORNHILL SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | St Paul's House Warwick Lane EC4M 7BP London | 900023430001 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 8th Floor 20 Farringdon Street EC4A 4AB London C/O Tmf Group United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| WIGMORE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 38 Wigmore Street W1U 2HA London | 900030910001 | |||||||||||
| ADAM, Patrick Paul | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Italy | Belgian | 247860460001 | |||||||||
| BOTTA, Giorgio | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | Italy | Italian | 165171170001 | |||||||||
| CHIERICONI, Sergio | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | United Kingdom | Italian | 184773730002 | |||||||||
| COLOMBO, Achille | Director | 20 Balcombe Street NW1 6NB London | Swiss | 85487490002 | ||||||||||
| CURRIE, Ewan Duncan | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | Scotland | British | 195241840001 | |||||||||
| DIBLEY, Richard Stewart | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | United Kingdom | British | 196689680002 | |||||||||
| FALCK, Enrico Ottaviano | Director | Via Olmetto Milan 21 Italy | Italy | Italian | 169518560001 | |||||||||
| FALCK, Enrico Ottaviano | Director | Via Olmetto Milan No.21 Italy | Italy | Italian | 169518560001 | |||||||||
| FALCK, Federico Sergio | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | Italy | Italian | 167739550001 | |||||||||
| FALCK, Federico Sergio Francesco | Director | Via Del Vecchio Politecnico 5 20121 Milan Italy | Italy | Italian | 138738520001 | |||||||||
| FERRARI, Massimo | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | Italy | Italian | 185269630001 | |||||||||
| GILBERT, William Scott, Mr. | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Scotland | British | 247860040002 | |||||||||
| HELLER, William Jacob, Mr. | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | England | Canadian | 93714130001 | |||||||||
| HELLER, William Jacob, Mr. | Director | 20 Balcombe Street NW1 6ND London | England | Canadian | 93714130001 | |||||||||
| MANZONI, Piero | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | Italy | Italian | 167739630001 | |||||||||
| MANZONI, Piero | Director | Via Cassinazza 5 27010 Giussago Pv Italy | Italy | Italian | 138738680001 | |||||||||
| MARGETTS, Robert John, Sir | Director | C/O Matlin Patterson 7th Floor Buchanan House SW1Y 4JU 3 St James's Square London | England | British | 11862560006 | |||||||||
| OXBURGH, Ernest Ronald, Lord | Director | 14 Bentley Road CB2 8AW Cambridge Cambridgeshire | England | British | 116247330001 | |||||||||
| PICTON-TURBERVILL, David | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | United Kingdom | British | 151647700001 | |||||||||
| PICTON-TURBERVILL, David | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | United Kingdom | British | 151647700001 | |||||||||
| PUNJ, Atul | Director | 10, Prithvi Raj Road FOREIGN New Delhi 110011 India | India | Indian | 114685720001 | |||||||||
| REDBURN, Timothy John | Director | Little Abbotts Snower Hill Road RH3 7AQ Betchworth Surrey | England | British | 22018030002 | |||||||||
| RUNDEDDU, Paolo Luigi | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | Italy | Italian | 148730710001 | |||||||||
| RUNDEDDU, Paolo Luigi | Director | Urbano 111 Milan No.3 Italy | Italy | Italian | 148730710001 | |||||||||
| SALA, Davide Vittorio | Director | 7-10 Beaumont Mews London W1G 6EB | England | Italian | 184722130002 | |||||||||
| SCALONE, Carmelo | Director | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Italy | Italian | 337835940001 | |||||||||
| SCHENK, Hans Rudolf | Director | Via Praccio 38 Massagno 6900 Ticino Switzerland | Switzerland | Swiss | 111131120001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RENANTIS UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Kevin Mccullough | 01 ene 2026 | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Clarence O'Neill Brown | 19 ene 2024 | 10 Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London Third Floor England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Nadara Limited | 10 ene 2024 | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Fourth Floor Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Michael Nagle | 18 may 2022 | Copyhold Lane Cuckfield RH17 5EB Haywards Heath The Limes England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Vumindaba Dube | 18 may 2022 | 2nd Floor One Nexus Way Camana Bay Suite 5b201 Ky1-1103 Cayman Islands | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Cayman Islander País de residencia: Cayman Islands | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Henry Fayne | 18 may 2022 | Apt 12e New York 140 East 83rd Street United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Falck Renewables Spa | 30 jun 2016 | 20121 Milan Corso Venezia 16 Italy | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0