BENNETTS UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBENNETTS UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04513095
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BENNETTS UK LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra BENNETTS UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Greater Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BENNETTS UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BROOMCO (2999) LIMITED16 ago 200216 ago 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BENNETTS UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BENNETTS UK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BENNETTS UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 16 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 sept 2014

    Estado de capital el 11 sept 2014

    • Capital: GBP 1,111.08
    SH01

    Cese del nombramiento de Georges Desray como director el 08 jul 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christian Charles Plumer como director el 08 jul 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Christian Charles Plumer como secretario el 08 jul 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Georges Desray como secretario el 08 jul 2014

    1 páginasTM02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2013

    Estado de capital el 02 sept 2013

    • Capital: GBP 1,111.08
    SH01

    Cambio de datos del director Georges Desray el 28 ago 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Georges Desray como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Sally Hargreaves como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Georges Desray como director

    2 páginasAP01

    second-filing-of-form-with-form-type

    4 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 feb 2012A SECOND FILED TM01 FOR PETER HALPIN WAS REGISTERED ON 24/02/2012

    second-filing-of-form-with-form-type

    4 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 feb 2012A SECOND FILED TM01 FOR ANTHONY CLARE WAS REGISTERED ON 24/02/2012

    Cese del nombramiento de Charles Bellringer como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Haplin como director

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 feb 2012A SECOND FILED TM01 FOR PETER HALPIN WAS REGISTERED ON 24/02/2012

    Nombramiento de Christophe Marie Fred Bardet como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Charles Albert John Bellringer como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony Clare como director

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 feb 2012A SECOND FILED TM01 FOR ANTHONY CLARE WAS REGISTERED ON 24/02/2012

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BENNETTS UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    189557460001
    BARDET, Christophe Marie Fred
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrench165770320001
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish130813500001
    CUGGY, Victoria Louise
    Ranulf Road
    CM6 3GR Little Dunmow
    63
    Essex
    Secretario
    Ranulf Road
    CM6 3GR Little Dunmow
    63
    Essex
    British105782010002
    DARBYSHIRE, Ian Simpson
    High Barn
    Flasby
    BD23 3PU Skipton
    North Yorkshire
    Secretario
    High Barn
    Flasby
    BD23 3PU Skipton
    North Yorkshire
    British64545980001
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    169857490001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Secretario
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    British85213650001
    HARGREAVES, Sally Anne
    27 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DG Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    27 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DG Altrincham
    Cheshire
    English1778900007
    LANGLEY, John David
    Cloverfields
    Leys Lane
    HR6 0AZ Bircher
    Herefordshire
    Secretario
    Cloverfields
    Leys Lane
    HR6 0AZ Bircher
    Herefordshire
    British75990260001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secretario
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British46372950001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BELLRINGER, Charles Albert John
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish132720300001
    BODENHAM, Martin Philip
    Mulberry House
    Bowden Road
    LE16 7TP Thorpe Langton
    Leicestershire
    Director
    Mulberry House
    Bowden Road
    LE16 7TP Thorpe Langton
    Leicestershire
    British73925870003
    BOWN, Paul Anthony
    Chearsley House Church Lane
    Chearsley
    HP18 0DF Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Chearsley House Church Lane
    Chearsley
    HP18 0DF Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish61524600001
    CLARE, Anthony Peter
    25 Round Wood
    Penwortham
    PR1 0BN Preston
    Lancashire
    Director
    25 Round Wood
    Penwortham
    PR1 0BN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish51441260002
    DARBYSHIRE, Ian Simpson
    High Barn
    Flasby
    BD23 3PU Skipton
    North Yorkshire
    Director
    High Barn
    Flasby
    BD23 3PU Skipton
    North Yorkshire
    British64545980001
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandFrench167333040002
    HAPLIN, Peter Joseph
    Long Moss Lane
    New Longton
    PR4 4XN Preston
    Feniscliffe
    Lancashire
    Director
    Long Moss Lane
    New Longton
    PR4 4XN Preston
    Feniscliffe
    Lancashire
    United KingdomBritish135757830001
    HENDY, Robert Arthur
    21 Whitehead Drive
    Wellesbourne
    CV35 9PW Warwick
    Warwickshire
    Director
    21 Whitehead Drive
    Wellesbourne
    CV35 9PW Warwick
    Warwickshire
    British99792750001
    HUTTON, Michael
    40 The Locks
    BD16 4BG Bingley
    West Yorkshire
    Director
    40 The Locks
    BD16 4BG Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish78423980002
    JONES, Trevor Alexander
    Paddock Cottage
    Farm Close
    KT24 5AE East Horsley
    Surrey
    Director
    Paddock Cottage
    Farm Close
    KT24 5AE East Horsley
    Surrey
    British61273750002
    LANGLEY, John David
    Cloverfields
    Leys Lane
    HR6 0AZ Bircher
    Herefordshire
    Director
    Cloverfields
    Leys Lane
    HR6 0AZ Bircher
    Herefordshire
    United KingdomBritish75990260001
    MORLEY, James
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    Director
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom13374700001
    POTTS, Nicholas
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    Director
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    EnglandBritish64059360004
    RICHARDSON, Paul Scott
    Fyfe Lodge
    Southam Street
    CV35 0LL Kineton
    Warwickshire
    Director
    Fyfe Lodge
    Southam Street
    CV35 0LL Kineton
    Warwickshire
    British86330930001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    85 The Waterfront
    Mill Road
    SG14 1SD Hertford
    Hertfordshire
    Director
    85 The Waterfront
    Mill Road
    SG14 1SD Hertford
    Hertfordshire
    British98993590002
    WOODS, Mark Rex
    The Limes
    South Milford
    LS25 5NH Leeds
    1
    West Yorkshire
    Director
    The Limes
    South Milford
    LS25 5NH Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish179198120001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ¿Tiene BENNETTS UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of rental deposit
    Creado el 29 oct 2003
    Entregado el 07 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £16,638 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of fixed charge all its interest in the deposit account and in the deposit balance as security. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ukph NO1 Limited and Ukph NO2 Limited
    Transacciones
    • 07 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 13 dic 2002
    Entregado el 21 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £100,000 credited to account designation 88517136 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 nov 2002
    Entregado el 04 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Insurance Limited
    Transacciones
    • 04 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0