BENNETTS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BENNETTS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04513095 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BENNETTS UK LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra BENNETTS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Greater Manchester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BENNETTS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BROOMCO (2999) LIMITED | 16 ago 2002 | 16 ago 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BENNETTS UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BENNETTS UK LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BENNETTS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Georges Desray como director el 08 jul 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christian Charles Plumer como director el 08 jul 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Christian Charles Plumer como secretario el 08 jul 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Georges Desray como secretario el 08 jul 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Georges Desray el 28 ago 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Georges Desray como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sally Hargreaves como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Georges Desray como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 4 páginas | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 4 páginas | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Bellringer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Haplin como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Christophe Marie Fred Bardet como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Charles Albert John Bellringer como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Clare como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BENNETTS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUMER, Christian Charles | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 189557460001 | |||||||
| BARDET, Christophe Marie Fred | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | French | 165770320001 | |||||
| PLUMER, Christian Charles | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 130813500001 | |||||
| CUGGY, Victoria Louise | Secretario | Ranulf Road CM6 3GR Little Dunmow 63 Essex | British | 105782010002 | ||||||
| DARBYSHIRE, Ian Simpson | Secretario | High Barn Flasby BD23 3PU Skipton North Yorkshire | British | 64545980001 | ||||||
| DESRAY, Georges | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 169857490001 | |||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Secretario | Holliwell Chandlers CM0 8NY Burnham On Crouch Essex | British | 85213650001 | ||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Secretario | 27 Broad Lane Hale WA15 0DG Altrincham Cheshire | English | 1778900007 | ||||||
| LANGLEY, John David | Secretario | Cloverfields Leys Lane HR6 0AZ Bircher Herefordshire | British | 75990260001 | ||||||
| RINGROSE, Christopher James | Secretario | Lindum Lodge, Orchard Close Risby IP28 6QL Bury St Edmunds Suffolk | British | 46372950001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||
| BODENHAM, Martin Philip | Director | Mulberry House Bowden Road LE16 7TP Thorpe Langton Leicestershire | British | 73925870003 | ||||||
| BOWN, Paul Anthony | Director | Chearsley House Church Lane Chearsley HP18 0DF Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 61524600001 | |||||
| CLARE, Anthony Peter | Director | 25 Round Wood Penwortham PR1 0BN Preston Lancashire | United Kingdom | British | 51441260002 | |||||
| DARBYSHIRE, Ian Simpson | Director | High Barn Flasby BD23 3PU Skipton North Yorkshire | British | 64545980001 | ||||||
| DESRAY, Georges | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | French | 167333040002 | |||||
| HAPLIN, Peter Joseph | Director | Long Moss Lane New Longton PR4 4XN Preston Feniscliffe Lancashire | United Kingdom | British | 135757830001 | |||||
| HENDY, Robert Arthur | Director | 21 Whitehead Drive Wellesbourne CV35 9PW Warwick Warwickshire | British | 99792750001 | ||||||
| HUTTON, Michael | Director | 40 The Locks BD16 4BG Bingley West Yorkshire | England | British | 78423980002 | |||||
| JONES, Trevor Alexander | Director | Paddock Cottage Farm Close KT24 5AE East Horsley Surrey | British | 61273750002 | ||||||
| LANGLEY, John David | Director | Cloverfields Leys Lane HR6 0AZ Bircher Herefordshire | United Kingdom | British | 75990260001 | |||||
| MORLEY, James | Director | Virginia House St Marys Road SL5 9JE Ascot Berkshire | United Kingdom | United Kingdom | 13374700001 | |||||
| POTTS, Nicholas | Director | 4 Ringstone Kromlin Barkisland HX4 0EU Halifax | England | British | 64059360004 | |||||
| RICHARDSON, Paul Scott | Director | Fyfe Lodge Southam Street CV35 0LL Kineton Warwickshire | British | 86330930001 | ||||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Director | 85 The Waterfront Mill Road SG14 1SD Hertford Hertfordshire | British | 98993590002 | ||||||
| WOODS, Mark Rex | Director | The Limes South Milford LS25 5NH Leeds 1 West Yorkshire | England | British | 179198120001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
¿Tiene BENNETTS UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of rental deposit | Creado el 29 oct 2003 Entregado el 07 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £16,638 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción By way of fixed charge all its interest in the deposit account and in the deposit balance as security. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge of deposit | Creado el 13 dic 2002 Entregado el 21 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit initially of £100,000 credited to account designation 88517136 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 nov 2002 Entregado el 04 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0