CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04528405 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BROOMCO (3028) LIMITED | 06 sept 2002 | 06 sept 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2024 | 38 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 38 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Albany Secretariat Limited como secretario el 01 ago 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Ailison Louise Mitchell como secretario el 01 ago 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 37 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Katherine Victoria Morgan como director el 01 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Geoffrey David Holden como director el 01 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2021 | 36 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 13 mar 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 03 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Stephanie Ann Exell como director el 02 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Christopher Wayment como director el 02 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 34 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | Charlotte Street M1 4HB Manchester 3-5 England |
| 303585870001 | ||||||||||
| COWDELL, Jonathan Nigel Edward | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 185028930001 | |||||||||
| EXELL, Stephanie Ann | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | 261406680001 | |||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 190982570023 | |||||||||
| MORGAN, Katherine Victoria | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 289756560001 | |||||||||
| PAGE, Alastair Huw | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | 57997800001 | |||||||||
| PRIOR, Steven Marc | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 142912290002 | |||||||||
| LEEMING, Steven John | Secretario | 26 Bridle Road Woodford SK7 1QJ Stockport Cheshire | British | 99979300001 | ||||||||||
| MITCHELL, Ailison Louise | Secretario | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | British | 53150080001 | ||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||||||
| HLM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 1st Floor 25 Stamford Street WA14 1EX Altrincham Cheshire | 118686920001 | |||||||||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Director | The Venus, Rd Floor 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester Lancs | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Director | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||||||
| BARDEN, Philip Thomas | Director | 3 Fitzgerald Avenue SW14 8SZ London | England | British | 116520140001 | |||||||||
| BATE, Dennis | Director | 109 Carmill Road Billinge WN5 7TY Wigan Lancashire | British | 28569910001 | ||||||||||
| CARTER, Stuart Anthony | Director | 27 Hawker Road Ash Vale GU12 5SL Aldershot Hampshire | United Kingdom | British | 89521900002 | |||||||||
| CAVEN, Robin Graham | Director | 74 St Johns Road TN13 3NB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 76216840002 | |||||||||
| CHALMERS, Douglas Charles Robert | Director | Gubblecote HP23 4QG Tring Gubblecote Farm Hertfordshire | England | British | 152499570001 | |||||||||
| COLES, Lindsey Jane | Director | 1 Ashton Villas Main Road Colden Common SO21 1RS Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 97370350001 | |||||||||
| COLES, Lindsey Jane | Director | 1 Ashton Villas Main Road Colden Common SO21 1RS Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 97370350001 | |||||||||
| CONNOLLY, Aidan Joseph | Director | Ridgeways 18 Chiltern Hills Road HP9 1PL Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 100376210001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Director | 126 Broad Hinton RG10 0XH Twyford Berkshire | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| DEACON, Andrew Brian | Director | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | England | British | 184392260001 | |||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Director | The Venus, Rd Floor 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester Lancs | United Kingdom | British | 206362380001 | |||||||||
| HOCKADAY, Stephen | Director | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | 101894100001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 170508700001 | |||||||||
| JACKSON, Gregor Scott | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 191227420001 | |||||||||
| MCKENNA, Leo William | Director | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | Northern Ireland | Northern Irish | 164592610001 | |||||||||
| MILLETT, Jason David | Director | Barnwell 98 Watling Street Affetside BL8 3QL Bury Lancashire | British | 68041260001 | ||||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | Oaklands Crescent CM2 9PR Chelmsford 16 United Kingdom | England | British | 156461120001 | |||||||||
| MURPHY, Helen Mary | Director | The Venus, Rd Floor 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester Lancs | England | Irish | 156461710001 | |||||||||
| POCHON, Sebastien | Director | 42 Marney Road SW11 5EP London | British | 100976810001 | ||||||||||
| POTGIETER, Johan Hendrik | Director | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | England | South African | 173393140001 | |||||||||
| POWER, Antony David | Director | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | United Kingdom | British | 177465680002 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | 106 Grosvenor Road KT18 6JB Epsom Downs Surrey | United Kingdom | British | 123048390001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CATALYST HEALTHCARE (MANCHESTER) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civis Pfi / Ppp Infrastructure Fund Lp | 20 feb 2018 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Civis Pfi /Ppp Infrastructure Manchester Holdings Ltd | 03 sept 2016 | The Esplanade St Helier JE4 9WE Jersey 44 Jersey | Sí | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Sodexo Investment Services Ltd | 03 sept 2016 | Southampton Row WC1B 5HA London 1 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Infrared Infrastructure Yield Holdings Ltd | 03 sept 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 Charles Ii Street England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0