WHITE CORN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWHITE CORN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04542352
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WHITE CORN LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WHITE CORN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WHITE CORN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EWM (TOPCO) LIMITED07 nov 200607 nov 2006
    THE EDINBURGH WOOLLEN MILL (GROUP) LIMITED26 feb 200326 feb 2003
    EWM TOPCO LIMITED11 nov 200211 nov 2002
    INTERCEDE 1816 LIMITED23 sept 200223 sept 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WHITE CORN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WHITE CORN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    15 páginasLIQ14

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 19 jul 2021

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS United Kingdom a C/O Rsm Restructuring Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB el 04 ago 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos

    10 páginasLIQ02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Cese del nombramiento de Carmel Leigh como director el 30 jun 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Anthony Herring como director el 30 jun 2021

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 045423520009

    1 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de Global House 5 Castle Street Carlisle Cumbria CA3 8SY England a 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS el 18 jun 2021

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name14 jun 2021

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 jun 2021

    RES15

    Cese del nombramiento de Daniel Philip Day como director el 27 abr 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lauren Sarah Day como director el 27 abr 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Philip Edward Day como director el 27 abr 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 15 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de David Oliver Houston como director el 16 oct 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Daniel Philip Day como director el 15 sept 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr John Robert Jackson como director el 15 sept 2020

    2 páginasAP01

    Registro de la carga 045423520009, creada el 24 ago 2020

    19 páginasMR01

    Registro de la carga 045423520008, creada el 17 mar 2020

    26 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 02 mar 2019

    68 páginasAA

    Cambio de datos del director Miss Lauren Sarah Day el 01 nov 2018

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Miss Lauren Sarah Day el 24 jun 2016

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Robert Neil Edmonds como director el 07 jun 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de WHITE CORN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARRUTHERS, June
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    Secretario
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    British50519150001
    JACKSON, John Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Director
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    WalesBritish274337670001
    SIMPSON, Stephen Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Director
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    United KingdomBritish166820010002
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    DAY, Daniel Philip
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Director
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish226073480001
    DAY, Lauren Sarah
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Director
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish209763710001
    DAY, Philip Edward
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Director
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    SwitzerlandBritish46992150038
    EDMONDS, Robert Neil
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Director
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    EnglandBritish206608930001
    GERRARD, Paul John
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    Director
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    UkBritish159694080001
    HERRING, John Anthony
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Director
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish151442360001
    HERRING, John Anthony
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    Director
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    EnglandBritish151442360001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Director
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    HOUSTON, David Oliver
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Director
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    ScotlandBritish75910100005
    HOUSTON, David Oliver
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    Director
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    ScotlandBritish75910100005
    LEE, Kristian Brian
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    Director
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    EnglandBritish160887440001
    LEIGH, Carmel
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Director
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish104858030003
    LIGHT, David Arthur
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    Director
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish45750750003
    WHITAKER, Alec
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    Director
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    EnglandBritish60593850003
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WHITE CORN LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    06 abr 2016
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalScottish Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc307281
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene WHITE CORN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 24 ago 2020
    Entregado el 26 ago 2020
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Not applicable.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 26 ago 2020Registro de una carga (MR01)
    • 05 jul 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 mar 2020
    Entregado el 17 mar 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    The chargor charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any other land, investments, equipment, intellectual property, goodwill, uncalled capital, authorisations, insurances it holds in relation to any security asset.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Edinburgh Woollen Mill (Group) Limited
    Transacciones
    • 17 mar 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 11 mar 2019
    Entregado el 14 mar 2019
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    Debenture
    Creado el 25 jul 2011
    Entregado el 29 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) and each bilateral lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    (For details of all trade marks charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 29 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 29 mar 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creado el 31 oct 2006
    Entregado el 08 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as the edinburgh wollen mill (group) limited to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 08 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creado el 25 feb 2005
    Entregado el 04 mar 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 04 mar 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Insurance assignment
    Creado el 14 may 2003
    Entregado el 16 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its right title and interest present and future in and to the policies and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Insurance assignment
    Creado el 15 abr 2003
    Entregado el 19 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policies being 5 year bassett life policy number ASL19086 in the name of philip day for the sum of £1,000,000 commencement date 01/03/03, 5 year legal & general policy number 0088395306 in the name of alec whitaker for the sum of £250,000 commencement date 01/03/03. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries
    Transacciones
    • 19 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 nov 2002
    Entregado el 20 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 20 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WHITE CORN LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 jul 2021Inicio de la liquidación
    08 abr 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gordon Thomson
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profesional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Damian Webb
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profesional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0