RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04547927 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1st Floor Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester Lancashire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ING RED UK (ROYAL MILLS) LTD | 27 nov 2003 | 27 nov 2003 |
| LONDON & AMSTERDAM DEVELOPMENTS (ANCOATS) LIMITED | 27 sept 2002 | 27 sept 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2020 au 31 mar 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Shaw como secretario el 18 nov 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Daren Whitaker el 06 feb 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Daren Whitaker el 30 ene 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITAKER, Daren | Director | Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester 1st Floor Lancashire England | England | British | 177268740005 | |||||
| COETZEE, Russell Steven | Secretario | 64 Ellerdale Street SE13 7JU London | British | 102287620001 | ||||||
| KHANAM, Samia | Secretario | 216 Lonsdale Avenue East Ham E6 3PP London | British | 78775890001 | ||||||
| MEAD, Stefan | Secretario | 82a Aslett Street SW18 2BQ London | British | 142492700001 | ||||||
| SHAW, Michael | Secretario | Floor Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester 1st Lancashire England | 174853240001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALKER, David | Director | Ludlow Avenue LU1 3RW Luton 16 Bedfordshire United Kingdom | England | British | 79215690001 | |||||
| BRAND, Hein Jacobus Pieter Willem | Director | Zuider Stationsweg 2061 HE Bloemendaa 2a Netherlands | Netherlands | Dutch | 165629010001 | |||||
| COETZEE, Russell Steven | Director | 64 Ellerdale Street SE13 7JU London | England | British | 102287620001 | |||||
| HOEKSMA, Siep | Director | Spade 47 Da Wieringerwerf Nh 1771 The Netherlands | Dutch | 56665150002 | ||||||
| KOOIJ, Marcel Antonius | Director | The Rise TN13 1RY Sevenoaks 55 Kent United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 127713020003 | |||||
| MATHIJSSEN, Sven Petrus Johannes Maria | Director | Senecalaan 20 Zeist 3707 Zn The Netherlands | Netherlands | Dutch | 124390040001 | |||||
| PARKER, Guy Trevor | Director | Cann Lane North Woodside Mews WA4 5NF Appleton Warrington Caxton House | England | British | 130108080001 | |||||
| PEARCE, Ian George Stanforth | Director | The Bell House Crowbrook Road, Askett HP27 9LS Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | United Kingdom | 2585440004 | |||||
| RAINFORD, Benedict John | Director | 5 Woodstock Road North AL1 4QB St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 54428250002 | |||||
| TAYLOR, Martin Laurence | Director | 20 Bushwood Road Kew TW9 3BQ Richmond Surrey | England | British | 6069400002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon Developments (Manchester) Limited | 06 abr 2016 | Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester 1st Floor Lancashire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 05 jul 2013 Entregado el 24 jul 2013 | Pendiente | ||
Breve descripción Kennedy building paragon mill and royal mill being land and buildings at henry street jersey street and redhill street ancoats manchester t/no MAN204533 and part only t/no GM974265. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage and debenture | Creado el 12 ago 2004 Entregado el 31 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first charge all plant and machinery all computers vehicles office equipment and other equipment the benefit of all contracts licences and warranties by way of first floating charge all its present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over bank accounts | Creado el 12 ago 2004 Entregado el 31 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all its right title and interest in the accounts and the charged balance the accounts being the sales proceeds account development expenditure account numbered 10105643 sort code 20-65-63 and designated ing red UK (royal mills)sales proceeds account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0