LS REALISATIONS LIMITED

LS REALISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLS REALISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04552005
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LS REALISATIONS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LS REALISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LS REALISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LAIDLAW SOLUTIONS LIMITED24 sept 200324 sept 2003
    EDGER 310 LIMITED02 oct 200202 oct 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LS REALISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LS REALISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 14 dic 2016

    19 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 14 dic 2016

    19 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 17 jun 2016

    37 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    4 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    49 páginas2.17B

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed laidlaw solutions LIMITED\certificate issued on 15/01/16
    3 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 06 ene 2016

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Domicilio social registrado cambiado de Leaderflush Shapland Milnhay Road Langley Mill Nottingham NG16 4AZ a 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ el 08 ene 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 dic 2015

    Estado de capital el 04 dic 2015

    • Capital: GBP 146,664
    SH01

    Nombramiento de Mr Edward John Riley como director el 21 oct 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Edward Riley como secretario el 30 sept 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Peter Thomond O'brien como director el 21 oct 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan Sime como secretario el 30 sept 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Alan Sime como director el 30 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ian Colin Hopkinson como director el 25 jun 2015

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2014 au 31 dic 2014

    1 páginasAA01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2015 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Alan Sime como secretario el 28 nov 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Alison Ruth Hoskin como secretario el 28 nov 2014

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 02 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 nov 2014

    Estado de capital el 28 nov 2014

    • Capital: GBP 146,664
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    23 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LS REALISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RILEY, Edward
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Secretario
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    202660280001
    JEFFERIES, John
    2 Long Hey Way
    Caldy
    CH48 1LZ Wirral
    Croft Lodge
    Merseyside
    United Kingdom
    Director
    2 Long Hey Way
    Caldy
    CH48 1LZ Wirral
    Croft Lodge
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish132190060001
    RILEY, Edward John
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Director
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    EnglandBritish60757430002
    BEECH, David Shaun
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    Secretario
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    153551240001
    CLARK, Trevor John
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    Secretario
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    174197310001
    CUTHBERTSON, John William
    Hillcote 7 Linton Avenue
    LS22 6SQ Wetherby
    West Yorkshire
    Secretario
    Hillcote 7 Linton Avenue
    LS22 6SQ Wetherby
    West Yorkshire
    British96511610001
    HOSKIN, Alison Ruth
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    Secretario
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    181521530001
    JEFFERIES, John
    6 Heatherleigh
    Caldy
    CH48 1QZ Wirral
    Merseyside
    Secretario
    6 Heatherleigh
    Caldy
    CH48 1QZ Wirral
    Merseyside
    British83647600001
    REARDON, Timothy Philip
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    Secretario
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    British91906070001
    SIME, Alan
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    Secretario
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    193062960001
    WALKER, Alastair James
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    Secretario
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    British123331600001
    CRESCENT HILL LIMITED
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    Secretario designado corporativo
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    900024050001
    CLEMENT, Craig Darren
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    Director
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    EnglandBritish102403040003
    CROSS, Stevan Paul
    6 Marling Close
    WA6 6AY Frodsham
    Cheshire
    Director
    6 Marling Close
    WA6 6AY Frodsham
    Cheshire
    British93218310001
    HOPKINSON, Ian Colin
    Bryn Celyn
    Berth Ddu, Rhosesmor
    CH7 6PS Mold
    Clwyd
    Director
    Bryn Celyn
    Berth Ddu, Rhosesmor
    CH7 6PS Mold
    Clwyd
    WalesBritish76627690001
    O'BRIEN, Peter Thomond
    16 St Johns Road
    WA16 0DP Knutsford
    Cheshire
    Director
    16 St Johns Road
    WA16 0DP Knutsford
    Cheshire
    EnglandEnglish,Irish54240700002
    REARDON, Timothy Philip
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    Director
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    British91906070001
    SIME, Alan
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    Director
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    EnglandBritish51759580002
    WALKER, Alastair James
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    Director
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    United KingdomBritish123331600001
    ST ANDREWS COMPANY SERVICES LIMITED
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    Director designado corporativo
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    900024040001

    ¿Tiene LS REALISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 may 2013
    Entregado el 07 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Accession deed to a debenture dated 17 september 2012 creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of laidlaw solutions limited, as more particularly described in clause 5 of the accession deed.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ashwani Malhan
    Transacciones
    • 07 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 22 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 23 may 2013
    Entregado el 07 jun 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Accession deed to a debenture dated 1 august 2011 creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of laidlaw solutions limited, as more particularly described in clause 5 of the accession deed.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rutland Partners LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transacciones
    • 07 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    All asset debenture
    Creado el 20 dic 2012
    Entregado el 22 dic 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Units 1 and 2 north muirton industrial estate arran road perth scotland t/no pth 20021 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 22 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 18 nov 2009
    Entregado el 20 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 15 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 25 jun 2009
    Entregado el 27 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 16 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 20 ene 2006
    Entregado el 24 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit sum of £5,625.
    Personas con derecho
    • Ian Joseph Warfield, David Andrew Jones, Wayne Ernest Abuzaid and Union Pension Trusteeslimited
    Transacciones
    • 24 ene 2006Registro de un cargo (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17/11/03 and
    Creado el 02 oct 2003
    Entregado el 04 dic 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Units 1 & 2 north muirton estate arran road perth PK1 3DE.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 04 dic 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 02 oct 2003
    Entregado el 22 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property k/a land on the west side of neachells lane, wednesfield t/nos WM518802, WM419610 and WM522122.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 22 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 02 oct 2003
    Entregado el 22 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    L/H property k/a unit a dakota avenue, salford, greater manchester t/no GM474433.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 22 oct 2003Registro de un cargo (395)
    All assets debenture
    Creado el 02 oct 2003
    Entregado el 10 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 10 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Security agreement
    Creado el 02 oct 2003
    Entregado el 06 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Ir Security & Safety Limited
    Transacciones
    • 06 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LS REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 dic 2015Inicio de la administración
    14 dic 2016Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Michael Hawes
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0