CROSS KEYS HOMES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CROSS KEYS HOMES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Convertida/Cerrada |
| Forma jurídica | Convertida o cerrada |
| Número de empresa | 04557701 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CROSS KEYS HOMES LIMITED?
- Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra CROSS KEYS HOMES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CROSS KEYS HOMES LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2018 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CROSS KEYS HOMES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misceláneos Forms b and z convert to rs | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Carl Paul Samuel Larter el 18 sept 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Robert Orrey como director el 18 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Samantha Jane Peeroo como director el 18 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Frederick White Holdich como director el 18 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angus John Kennedy como director el 18 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Carl Paul Samuel Larter el 06 sept 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Elizabeth Ellen Bisset el 06 sept 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 71 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Suzanne O'brien el 17 jul 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Claire Patricia Higgins el 26 abr 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Suzanne O'brien como director el 21 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Samuel como director el 20 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Carl Paul Samuel Larter el 24 nov 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Registro de la carga 045577010004, creada el 23 dic 2016 | 19 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 86 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Wayne Fitzgerald como director el 19 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart John Bradbury como director el 19 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Betty Diane Lamb como director el 19 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Rachel Louise Blakemore como director el 18 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Carl Paul Samuel Larter el 04 dic 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christine Cunningham como director el 10 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CROSS KEYS HOMES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGGINS, Claire Patricia | Secretario | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | 192784270001 | |||||||
| BELL, Donald James | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | English | 66039210003 | |||||
| BISSET, Elizabeth Ellen | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 201520160001 | |||||
| BLAKEMORE, Rachel Louise | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 206678580001 | |||||
| HIGGINS, Claire Patricia | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 147171510001 | |||||
| LAMB, Betty Diane, Cllr | Director | Shrewsbury Avenue PE2 7BZ Peterborough Cross Keys Homes England | Uk | British | 215163280001 | |||||
| LARTER, Carl Paul Samuel | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 130638260011 | |||||
| O'BRIEN, Suzanne | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | Irish | 176644930004 | |||||
| ORREY, Andrew Robert | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 238173050001 | |||||
| PEEROO, Samantha Jane | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 238199740001 | |||||
| LEGGETT, Michael John | Secretario | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | British | 213940800001 | ||||||
| PERRY, Paul James | Secretario | Flat 1 - 16 Notting Hill Gate Notting Hill W11 3JE London | British | 104807410001 | ||||||
| BAIN, Isobel Margaret | Director | 93 Lessingham Orton Brimbles PE2 5TR Peterborough Cambridgeshire | British | 90475320001 | ||||||
| BEECHAM, Kwamena | Director | 71 Caspian Way DA10 0LD Swanscombe Kent | British | 53444090002 | ||||||
| BRADBURY, Stuart John | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 181670230001 | |||||
| BROWN, Cyril | Director | 66 Loxley Werrington PE4 5BW Peterborough | British | 98599550001 | ||||||
| CHALMERS, Audrey | Director | 12 Swain Court PE2 9PL Peterborough Cambridgeshire | British | 10421750002 | ||||||
| CODDINGTON, Jill | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 98599580001 | |||||
| CUNNINGHAM, Christine | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 56941200001 | |||||
| FITZGERALD, Wayne | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 48900760002 | |||||
| FORDER, Ronald | Director | 92 Wildlake Orton Malborne PE2 5PQ Peterborough Cambridgeshire | British | 115711240001 | ||||||
| HOLDICH, John Frederick White | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 67625840001 | |||||
| JARVIS, Jonathan Edward Madison | Director | Flat 1 Mayfair Court 15 Park Hill Rise CR0 5RU Croydon | British | 65969460001 | ||||||
| KENNEDY, Angus John, Dr | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 81502080001 | |||||
| KHAZAI, Kamran | Director | 62 Park Road PE1 2YA Peterborough Apartment 47 Cambs | England | British | 132400260001 | |||||
| LANE, Stephen | Director | 69 Ploverly PE4 6JX Peterborough Cambridgeshire | British | 114403720001 | ||||||
| LEE, Benjamin Lawson | Director | Barn Lodge Ashton PE9 3BA Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 98599510001 | |||||
| LENTON, Paul | Director | 3 Gatenby Werrington PE4 6JU Peterborough | British | 98599600001 | ||||||
| LOW, Gordon Bernard | Director | Hinchcliffe Orton Goldhay PE2 5RH Peterborough 216 Cambs | British | 129980970001 | ||||||
| MCMANUS, William James | Director | 18 Bramble End PE28 5QH Sawtry Cambridgeshire | British | 98599530001 | ||||||
| MERRILL, Jason Marc | Director | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 154320360002 | |||||
| MURPHY, Graham | Director | 108 Crowland Road Eye PE6 7TR Peterborough Cambridgeshire | British | 96788530001 | ||||||
| MURRAY, Edward John | Director | Little Northfields Barnack PE9 3DR Stamford 12 Lincolnshire | United Kingdom | British | 133352720001 | |||||
| NASH, Patricia Ann | Director | 68 Barnstock Bretton PE3 8EJ Peterborough | British | 81325330001 | ||||||
| NEWTON, Harry, Cllr | Director | 18 Overstone Court Westwood PE3 7JE Peterborough Cambridgeshire | British | 99641200001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CROSS KEYS HOMES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough City Council | 06 abr 2016 | Bridge Street PE1 1QT Peterborough Town Hall England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene CROSS KEYS HOMES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 23 dic 2016 Entregado el 05 ene 2017 | Pendiente | ||
Breve descripción Property k/a 21-51 (odd) charlotte way netherton peterborough cambridgeshire t/no CB384103. Please see image for details of further property cahrged. Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplementary legal charge supplemental to a debenture dated 4 october 2004 and | Creado el 11 ene 2010 Entregado el 26 ene 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción 1-12 hedda drive, hampton hargate, peterborough t/n CB308603. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplementary legal charge | Creado el 17 sept 2008 Entregado el 19 sept 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada The secured liabilities as defined in the debenture | |
Breve descripción 354-378 (even) eagle way hampton town centre peterborough t/no. CB298943, 2-12 (even) bank avenue hampton town centre peterborough and 18 brickstead road hampton town centre peterborough t/no.CB325199 for details of further property charged please refer to form 395. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 oct 2004 Entregado el 14 oct 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to each finance party and each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The f/h and l/h properties in the peterborough district forming the housing stock of peterborough city council and indentified in a form TP3 and various leases between peterborough city council and the company, together with all buildings and fixtures,plant and machinery, insurances, floating charge the undertaking and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0