CASTLEGATE 795 LIMITED

CASTLEGATE 795 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTLEGATE 795 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04575239
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTLEGATE 795 LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INDEPENDENT INSPECTIONS HOLDINGS LIMITED23 may 200623 may 2006
    SRW HOLDINGS LIMITED06 ene 200406 ene 2004
    JOKASTDA LIMITED28 oct 200228 oct 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Modification des détails de Independent Group (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2023

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Cossey Cosec Services Limited como secretario el 25 ene 2023

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Rjp Secretaries Limited como secretario el 25 ene 2023

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW el 06 ene 2023

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Gold Round Limited el 25 jul 2022

    1 páginasCH02

    Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jul 2022

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2021

    7 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed independent inspections holdings LIMITED\certificate issued on 22/04/22
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name22 abr 2022

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 19 abr 2022

    RES15

    Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2021 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 21 jul 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2020

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alan Albert Horton como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2020 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 29 jun 2020

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL el 12 ago 2019

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Independent Group (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 ago 2019

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del secretario Rjp Secretaries Limited el 09 ago 2019

    1 páginasCH04

    Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 6

    2 páginasMR05

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director corporativo
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro05687325
    149588400001
    DICKINSON, Louise
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Secretario
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director139480580001
    POLLARD, Niall Mackinlay
    57 Royton Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HJ Preston
    Lancashire
    Secretario
    57 Royton Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HJ Preston
    Lancashire
    British176786520001
    WEST, Deborah
    3 Lavender Close
    Fulwood
    PR2 9RA Preston
    Lancashire
    Secretario
    3 Lavender Close
    Fulwood
    PR2 9RA Preston
    Lancashire
    British91741940001
    WILLS, Stephen Robert
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Secretario
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    BritishCompany Director35049690003
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02989995
    61999120002
    BARRETT, John
    3 Rockfield Close
    TQ14 8TS Teignmouth
    Devon
    Director
    3 Rockfield Close
    TQ14 8TS Teignmouth
    Devon
    United KingdomBritishDirector118475070001
    DICKINSON, Louise
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Director
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director139480580001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector182208240001
    LEE, Peter Francis
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Director
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishFinance Director207608120001
    LEES, Stuart
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Director
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritishDirector70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Director
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritishChief Executive180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Director
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritishDirector63238350002
    MAUDE, Simon David
    Bowser
    Old Mount Road
    HD7 6NN Marsden
    West Yorkshire
    Director
    Bowser
    Old Mount Road
    HD7 6NN Marsden
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector89719660002
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Director
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant108973030002
    POLLARD, Niall Mackinlay
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Director
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritishDirector176786520001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Director
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector207506140001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Director
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritishDirector99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Director
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector127928260002
    WILLS, Kathleen Jean
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Lancashire
    Director
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director61097710002
    WILLS, Stephen Robert
    Whitelodge 141 Hardhorn Road
    FY6 8ES Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Director
    Whitelodge 141 Hardhorn Road
    FY6 8ES Poulton Le Fylde
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director35049690004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18 abr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06732498
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CASTLEGATE 795 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 sept 2016
    Entregado el 13 sept 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Blackstar 2016 Limited
    Transacciones
    • 13 sept 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 03 jun 2016
    Entregado el 16 jun 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Secure Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 31 ene 2011
    Entregado el 08 feb 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transacciones
    • 08 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 28 mar 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 28 mar 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 26 jun 2009
    Entregado el 02 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited(Investor)
    Transacciones
    • 02 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 31 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 jun 2009
    Entregado el 30 jun 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 30 jun 2009Registro de un cargo (395)
    Accession deed
    Creado el 18 jul 2006
    Entregado el 20 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Bank PLC in Its Capacity as Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transacciones
    • 20 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 feb 2004
    Entregado el 27 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 2002
    Entregado el 03 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    38,44 and 46 avenham st,preston,lancs; t/no la 183448. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0