CASTLEGATE 795 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CASTLEGATE 795 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04575239 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CASTLEGATE 795 LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra CASTLEGATE 795 LIMITED?
Dirección de la sede social | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLEGATE 795 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
INDEPENDENT INSPECTIONS HOLDINGS LIMITED | 23 may 2006 | 23 may 2006 |
SRW HOLDINGS LIMITED | 06 ene 2004 | 06 ene 2004 |
JOKASTDA LIMITED | 28 oct 2002 | 28 oct 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLEGATE 795 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLEGATE 795 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Modification des détails de Independent Group (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nombramiento de Cossey Cosec Services Limited como secretario el 25 ene 2023 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rjp Secretaries Limited como secretario el 25 ene 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW el 06 ene 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Gold Round Limited el 25 jul 2022 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jul 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed independent inspections holdings LIMITED\certificate issued on 22/04/22 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2021 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 21 jul 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Albert Horton como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2020 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 29 jun 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL el 12 ago 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Independent Group (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 ago 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Rjp Secretaries Limited el 09 ago 2019 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 6 | 2 páginas | MR05 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CASTLEGATE 795 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
PACE, Stuart | Director | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | Director | 207506130003 | ||||||||
GOLD ROUND LIMITED | Director corporativo | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
DICKINSON, Louise | Secretario | 6 Fulwood Park Caxton Road, Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | British | Company Director | 139480580001 | |||||||||
POLLARD, Niall Mackinlay | Secretario | 57 Royton Drive Whittle Le Woods PR6 7HJ Preston Lancashire | British | 176786520001 | ||||||||||
WEST, Deborah | Secretario | 3 Lavender Close Fulwood PR2 9RA Preston Lancashire | British | 91741940001 | ||||||||||
WILLS, Stephen Robert | Secretario | 5 The Orchard Little Eccleston PR3 0YX Preston | British | Company Director | 35049690003 | |||||||||
RJP SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
BARRETT, John | Director | 3 Rockfield Close TQ14 8TS Teignmouth Devon | United Kingdom | British | Director | 118475070001 | ||||||||
DICKINSON, Louise | Director | 6 Fulwood Park Caxton Road, Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | Company Director | 139480580001 | ||||||||
HORTON, Alan Albert | Director | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | Director | 182208240001 | ||||||||
LEE, Peter Francis | Director | 6 Fulwood Park Caxton Road, Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | United Kingdom | British | Finance Director | 207608120001 | ||||||||
LEES, Stuart | Director | 6 Fulwood Park Caxton Road, Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | Director | 70032700001 | ||||||||
LLOYD JONES, Andrew Mark | Director | 6 Fulwood Park Caxton Road, Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | Chief Executive | 180809810001 | ||||||||
MAHONEY, Kevin David | Director | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | Director | 63238350002 | ||||||||
MAUDE, Simon David | Director | Bowser Old Mount Road HD7 6NN Marsden West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 89719660002 | ||||||||
MCINNES, Timothy Ian | Director | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 108973030002 | ||||||||
POLLARD, Niall Mackinlay | Director | 6 Fulwood Park Caxton Road, Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | Director | 176786520001 | ||||||||
SMITH, Andrew John | Director | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | England | British | Director | 207506140001 | ||||||||
VINCENT, Michael | Director | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | Director | 99258270001 | ||||||||
WATKINS, Steven James | Director | Park Crescent TR11 2DL Falmouth 1 Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 127928260002 | ||||||||
WILLS, Kathleen Jean | Director | 5 The Orchard Little Eccleston PR3 0YX Preston Lancashire | British | Company Director | 61097710002 | |||||||||
WILLS, Stephen Robert | Director | Whitelodge 141 Hardhorn Road FY6 8ES Poulton Le Fylde Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 35049690004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CASTLEGATE 795 LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Round Limited | 18 abr 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Independent Group (Uk) Limited | 06 abr 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CASTLEGATE 795 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 01 sept 2016 Entregado el 13 sept 2016 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 03 jun 2016 Entregado el 16 jun 2016 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A composite guarantee and debenture | Creado el 31 ene 2011 Entregado el 08 feb 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 26 jun 2009 Entregado el 02 jul 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 26 jun 2009 Entregado el 30 jun 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Accession deed | Creado el 18 jul 2006 Entregado el 20 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 19 feb 2004 Entregado el 27 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 18 dic 2002 Entregado el 03 ene 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 38,44 and 46 avenham st,preston,lancs; t/no la 183448. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0