TALAR-MADE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTALAR-MADE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04575555
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TALAR-MADE LIMITED?

    • Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32500) / Industrias manufactureras
    • Comercio al por mayor de productos farmacéuticos (46460) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra TALAR-MADE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Edinburgh House
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Derbyshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TALAR-MADE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TALAR-MADE CUSTOM ORTHOTICS LTD07 ago 200307 ago 2003
    ORTHOCAD LIMITED29 oct 200229 oct 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TALAR-MADE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 abr 2026
    Próximas cuentas vencen el31 ene 2027
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TALAR-MADE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 mar 2027
    Próxima declaración de confirmación vence25 mar 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 mar 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TALAR-MADE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 11 mar 2026 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Francis Barrett como director el 01 feb 2026

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2025

    10 páginasAA

    Cessation de Bernard Martin Crewdson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 jul 2025

    1 páginasPSC07

    Notification de Spire Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 jul 2025

    2 páginasPSC02

    Memorándum y Estatutos

    44 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Donna Marie Crewdson como director el 18 jul 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis Barrett como director el 18 jul 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Benjamin Dickinson como director el 18 jul 2025

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 045755550006, creada el 18 jul 2025

    42 páginasMR01

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    18 jul 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHASED

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 05 jun 2025

    • Capital: GBP 836
    4 páginasSH06

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 11 mar 2024

    3 páginasRP04CS01

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 11 mar 2025

    3 páginasRP04CS01

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03

    Declaración de confirmación presentada el 11 mar 2025 sin actualizaciones

    4 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    02 jul 2025Clarification A second filed CS01 (shareholder information change) was registered on 02/07/2025.

    Modification des détails de Mr Bernard Martin Crewdson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 mar 2025

    2 páginasPSC04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2024

    10 páginasAA

    11/03/24 Statement of Capital gbp 836

    6 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    02 jul 2025Clarification A second filed CS01 (Statement of capital & Shareholder information change) was registered on 02/07/2025.

    Modification des détails de Mr Bernard Martin Crewdson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2021

    2 páginasPSC04

    Cese del nombramiento de Hugh Ian Leddy como director el 29 feb 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Francis Barrett como director el 29 feb 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2023

    10 páginasAA

    Cese del nombramiento de Martin James Nicholson como secretario el 31 oct 2023

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de TALAR-MADE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    THOMAS, Ryan
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Secretario
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    315347940001
    BARRETT, Francis
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Director
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish244277170001
    CREWDSON, Bernard Martin
    Springwood House
    Cowley Lane, Holmesfield
    S18 7SD Dronfield
    Derbyshire
    Director
    Springwood House
    Cowley Lane, Holmesfield
    S18 7SD Dronfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish30665950003
    THOMAS, Ryan James
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Director
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish315158230001
    LACEY, Barbara Christine
    St. Andrews Walk
    LN10 6PF Woodhall Spa
    26
    Lincolnshire
    Secretario
    St. Andrews Walk
    LN10 6PF Woodhall Spa
    26
    Lincolnshire
    British81268530001
    NICHOLSON, Martin James
    Foxwood Way
    S41 9RN Chesterfield
    Springwood House
    Derbyshire
    England
    Secretario
    Foxwood Way
    S41 9RN Chesterfield
    Springwood House
    Derbyshire
    England
    British176527560001
    SHAW, Ian Robert
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    Secretario
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    168594290001
    BARRETT, Francis
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Director
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish244277170001
    BRADBURY, Rob
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish166782440001
    BRADBURY, Robert Andrew
    Stoney Leas
    Pool Green
    SN13 9SN Neston
    Wiltshire
    Director
    Stoney Leas
    Pool Green
    SN13 9SN Neston
    Wiltshire
    British99320870001
    CREWDSON, Donna Maria
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Director
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish49423180003
    CREWDSON, Donna Maria
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish49423180003
    DICKINSON, Simon Benjamin
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Director
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish182368140001
    LACEY, Barbara Christine
    St. Andrews Walk
    LN10 6PF Woodhall Spa
    26
    Lincolnshire
    Director
    St. Andrews Walk
    LN10 6PF Woodhall Spa
    26
    Lincolnshire
    United KingdomBritish81268530002
    LEDDY, Hugh Ian
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    Director
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish168599800001
    MILLS, Andrew James
    148 Totley Brook Road
    Dore
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    148 Totley Brook Road
    Dore
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British75578220001
    MILLS, James Peter
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish85279990002
    NICHOLSON, Martin James
    Foxwood Way
    S41 9RN Chesterfield
    Springwood House
    Derbyshire
    England
    Director
    Foxwood Way
    S41 9RN Chesterfield
    Springwood House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish73143880001
    QUINN, Steven Gregory
    12 Strelley Avenue
    Beauchief
    S8 0BG Sheffield
    Director
    12 Strelley Avenue
    Beauchief
    S8 0BG Sheffield
    EnglandEnglish53512780003
    SHAW, Ian Robert
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Springwood House
    Foxwood Way Sheepbridge
    S41 9RN Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish168593900002
    WELLS, Philip
    5 Mint Grove
    Penney Field Estate
    NG10 3QS Long Eaton
    Director
    5 Mint Grove
    Penney Field Estate
    NG10 3QS Long Eaton
    British88804780002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TALAR-MADE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    England
    18 jul 2025
    Millennium Way
    S41 8ND Chesterfield
    Edinburgh House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro16543908
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Mr Bernard Martin Crewdson
    Foxwood Industrial Park
    Foxwood Way
    S41 9RN Chesterfield
    Springwood House
    England
    06 abr 2016
    Foxwood Industrial Park
    Foxwood Way
    S41 9RN Chesterfield
    Springwood House
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0