GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED

GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04582176
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED?

    • Establecimientos residenciales de cuidados de enfermería (87100) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cancelación total de la carga 045821760007

    1 páginasMR04
    X932DMQW

    Cancelación total de la carga 045821760006

    1 páginasMR04
    X932CHQJ

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04
    X91W6YP4

    Cancelación total de la carga 045821760008

    1 páginasMR04
    X91W6Z5M

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04
    X91W70F4

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04
    X91W71AB

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04
    X91W74W9

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A8ZMFZCW

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    2 páginasAA
    X8KH3VBU

    Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X8HLBFX4

    Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X7I2LDM3

    Notification de Consensus Support Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02
    X7GR6LGQ

    Cessation de Paul Anthony Keith Jeffery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC07
    X7GR6DQX

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    2 páginasAA
    X7EYWUYI

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    2 páginasAA
    X6JSCSZC

    Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X6ISPNQ0

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    6 páginasAA
    L5LDE6AX

    Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X5J87LWX

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    9 páginasAA
    L4LHL6ZN

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2015

    Estado de capital el 05 nov 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X4JI2YCI

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2014

    Estado de capital el 05 nov 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X3K1L0PL

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    9 páginasAA
    A3FED73U

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 nov 2013

    Estado de capital el 08 nov 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X2KOIFBM

    ¿Quiénes son los directivos de GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Secretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Secretario
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    BritishDeveloper154122490001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Stable House
    Cockaynes Lane Alresford
    CO7 8BZ Colchester
    Essex
    Secretario
    Stable House
    Cockaynes Lane Alresford
    CO7 8BZ Colchester
    Essex
    BritishAccountant65609290003
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Director
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Consultant154122490001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Paul Anthony Keith Jeffery
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    06 abr 2016
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    Consensus Support Services Limited
    830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House
    England
    06 abr 2016
    830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro4081379
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GRAMMAR SCHOOL HOUSE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 11 sept 2013
    Entregado el 19 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 19 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 30 mar 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 11 sept 2013
    Entregado el 17 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Griffin-American Healthcare Reit Ii, Inc
    Transacciones
    • 17 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 16 abr 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 11 sept 2013
    Entregado el 16 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ga Hc Reit Ii Ch UK Senior Housing Portfolio LTD
    Transacciones
    • 16 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 16 abr 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 30 mar 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 nov 2007
    Entregado el 27 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 oct 2005
    Entregado el 03 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transacciones
    • 03 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 31 mar 2003
    Entregado el 02 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Share capital of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2020Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0