TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED

TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTLLC PROPHOLDCO1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04588799
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PLANTDRIFT LIMITED13 nov 200213 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    13 páginasAA

    Registro de la carga 045887990006, creada el 29 nov 2013

    148 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Grant David Hearn como director el 25 nov 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Peter Darren Gowers como director el 25 nov 2013

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2013

    Estado de capital el 05 nov 2013

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Joanna Boydell como director el 19 mar 2013

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Joanna Boydell como secretario el 19 mar 2013

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 28 mar 2013

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como secretario el 28 mar 2013

    2 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    legacy

    16 páginasMG01

    Cese del nombramiento de Guy Paul Cuthbert Parsons como director el 20 abr 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    18 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Auth sect 175 12/03/2010
    RES13

    Cambio de datos del director Paul Victor Harvey el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Guy Paul Cuthbert Parsons el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Grant David Hearn el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    British164373820001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer164373820001
    GOWERS, Peter Darren
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director157443090002
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant116809270002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    BritishProperty Director141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Secretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    BritishCompany Director93906210001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director88628480002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Director
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Director
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritishProperty Director141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Director
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    BritishDirector80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Director
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001

    ¿Tiene TLLC PROPHOLDCO1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 29 nov 2013
    Entregado el 05 dic 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Aberdeen airport burnside drive off riverview drive aberdeen t/no ABN84416, aberdeen bucksburn A96 inverurie road bucksburn aberdeen t/no ABN79397, aberdeen central justice mill lane aberdeen t/no ABN107231 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    A supplemental debenture
    Creado el 25 oct 2012
    Entregado el 31 oct 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 oct 2012Registro de un cargo (MG01)
    Security accession deed
    Creado el 26 sept 2006
    Entregado el 04 oct 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 04 oct 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 18 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transacciones
    • 18 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 18 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transacciones
    • 18 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 12 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transacciones
    • 12 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0