TLLC BRIDGECO10 LIMITED

TLLC BRIDGECO10 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTLLC BRIDGECO10 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04589588
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BOXCROFT LIMITED13 nov 200213 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    15 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 abr 2016

    15 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL el 04 nov 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 27 abr 2015

    LRESEX

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 14

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2014

    Estado de capital el 03 dic 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2013

    Estado de capital el 05 nov 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Mark Leslau el 17 sept 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Timothy James Evans el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Mark Leslau el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Miss Sandra Louise Gumm el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Secretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Australian57113450003
    EVANS, Timothy James
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritish104934670002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritish6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Secretario
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    British93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HARVEY, Paul Victor
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    Director
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    United KingdomBritish116809270002
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Director
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Director
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Director
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Director
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    Director
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    United KingdomBritish102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STOREY, Mark
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British121960950001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Director
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Director
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    ¿Tiene TLLC BRIDGECO10 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignation of rents
    Creado el 01 jun 2007
    Entregado el 12 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The assignor's entire right,title and interest in the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/06/2007 and
    Creado el 22 may 2007
    Entregado el 21 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H service area A1 old craighall musselburgh t/no MID43086.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 22 may 2007
    Entregado el 11 jun 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transacciones
    • 11 jun 2007Registro de un cargo (395)
    Assignation of rents dated 1 december 2006 and intimation dated
    Creado el 07 dic 2006
    Entregado el 20 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The rental income payable under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC, for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transacciones
    • 20 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 05 dic 2006
    Entregado el 13 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that property situated at harrow place london l/h t/n NGL636402 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The "Security Agent")
    Transacciones
    • 13 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 5 december 2006
    Creado el 01 dic 2006
    Entregado el 13 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H subjects k/a and forming the travelodge musselburgh service area, A1, old craighall, musselburgh t/no MID43086.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transacciones
    • 13 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 nov 2006
    Entregado el 18 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 18 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental leverage debenture relating to the original debenture
    Creado el 06 oct 2003
    Entregado el 18 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property being :-leasehold land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. 2) leasehold land consisting of the travelodge and little chef situated at the A1 northbound, new fox, south witham. 3) l/h land at shrewsbury road, mile end services, owestry, t/n SL47567.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotand PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transacciones
    • 18 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental term debenture relating to the original debenture
    Creado el 06 oct 2003
    Entregado el 18 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any finance party. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property being the l/h land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. L/h land the travelodge & little chef at A1 northbound, new fox, south witham, colsterworth. L/h land at shrewsbury road, mile end services, oswestry t/n SL47567.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transacciones
    • 18 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Creado el 01 oct 2003
    Entregado el 21 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Creado el 01 oct 2003
    Entregado el 21 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 18 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Including new fox north,south witham,lincolnshire; DY184164;derby rd,alfreton swanwick;SL47567 and mile end services,oswestry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transacciones
    • 18 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 12 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transacciones
    • 12 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TLLC BRIDGECO10 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 abr 2015Inicio de la liquidación
    06 dic 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Neil David Gostelow
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0