TLLC CMPROPCO8 LIMITED

TLLC CMPROPCO8 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTLLC CMPROPCO8 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04592829
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TLLC CMPROPCO8 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TLLC CMPROPCO8 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TLLC CMPROPCO8 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BREWSTERHURST LIMITED18 nov 200218 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TLLC CMPROPCO8 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TLLC CMPROPCO8 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    27 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 dic 2015

    49 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD el 24 dic 2014

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 10 dic 2014

    LRESEX

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    7 páginas4.20

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 dic 2014

    Estado de capital el 09 dic 2014

    • Capital: GBP 1,200,001
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 nov 2013

    Estado de capital el 11 nov 2013

    • Capital: GBP 1,200,001
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Mark Leslau el 17 sept 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    20 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Miss Sandra Louise Gumm el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Mark Leslau el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Miss Sandra Louise Gumm el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    13 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de TLLC CMPROPCO8 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Secretario
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Australian57113450003
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Director
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Director
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    United KingdomBritish6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Secretario
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    British93906210001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Director
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Director
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Director
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Director
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritish93906210001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Director
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Director
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    ¿Tiene TLLC CMPROPCO8 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Confirmatory security agreement
    Creado el 28 ene 2010
    Entregado el 04 feb 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 04 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    Security deed
    Creado el 19 oct 2004
    Entregado el 27 oct 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All f/h and l/h property, all buildings erections fixtures fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intercompany loans, goodwill & uncalled capital floating charge all assets not charged or assigned under the deed, all assets located in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Finance Parties(Security Agent)
    Transacciones
    • 27 oct 2004Registro de un cargo (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 27 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The subjects known as little chef,kingsway west,dundee (0.36 hectares),county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 27 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Little chef,kingsway west,dundee (0.36 hectares),county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 18 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Including lands at ludlow,shropshire,SL42880;bebington,wirral,MS298121;markham moor filling station,markham moor,nottinghamshire,NT294226. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transacciones
    • 18 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 12 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transacciones
    • 12 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TLLC CMPROPCO8 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 dic 2014Inicio de la liquidación
    30 dic 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Neil David Gostelow
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0