TLLC HOLDINGS5 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TLLC HOLDINGS5 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04592836 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TLLC HOLDINGS5 LIMITED?
Dirección de la sede social | Sleepy Hollow Aylesbury Road OX9 3AT Thame Oxfordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BREWSTERDALE LIMITED | 18 nov 2002 | 18 nov 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TLLC HOLDINGS5 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a Sleepy Hollow Aylesbury Road Thame Oxfordshire OX9 3AT el 08 feb 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de a G Secretarial Limited como secretario el 11 ene 2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Registro de la carga 045928360004 | 148 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Grant Hearn como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Darren Gowers como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Joanna Boydell como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Joanna Boydell como secretario | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon Mortimore como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon Mortimore como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 16 páginas | MG01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Guy Parsons como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYDELL, Joanna | Secretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | British | 164373820001 | ||||||
BOYDELL, Joanna | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 164373820001 | ||||
GOWERS, Peter Darren | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | England | British | Company Director | 157443090002 | ||||
HARVEY, Paul Victor | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 116809270002 | ||||
GARLAND, Michael Charles | Secretario | 21 Lichfield Road Kew Gardens TW9 3JR Richmond Surrey | Uk | Accountant | 174553070001 | |||||
HICKS, Christopher Michael | Secretario | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
MORTIMORE, Jon William | Secretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | |||||
SELLARS, Ian | Secretario | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | British | Director | 107731430001 | |||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
GARLAND, Michael Charles | Director | 21 Lichfield Road Kew Gardens TW9 3JR Richmond Surrey | United Kingdom | Uk | Accountant | 174553070001 | ||||
HEARN, Grant David | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | Company Director | 88628480002 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Director | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
LAYTON, Matthew Robert | Director designado | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
MORTIMORE, Jon William | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | ||||
PARKER, Carl Henry | Director | 82 Alleyn Road Dulwich SE21 8AH London | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 53480410003 | ||||
PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 102187770002 | ||||
RICHARDS, Martin Edgar | Director designado | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
SCOBLE, Timothy James | Director | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 83743120001 | ||||
SELLARS, Ian | Director | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | United Kingdom | British | Director | 107731430001 | ||||
TURNER, Harry | Director | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | Chief Operating Officer | 166789700001 |
¿Tiene TLLC HOLDINGS5 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 29 nov 2013 Entregado el 05 dic 2013 | Pendiente | ||
Breve descripción Aberdeen airport burnside drive off riverview drive aberdeen t/no ABN84416, aberdeen bucksburn A96 inverurie road bucksburn aberdeen t/no ABN79397, aberdeen central justice mill lane aberdeen t/no ABN107231 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A supplemental debenture | Creado el 25 oct 2012 Entregado el 31 oct 2012 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security accession deed | Creado el 26 sept 2006 Entregado el 04 oct 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 18 dic 2002 Entregado el 31 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All money or liabilities due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Including (I) property at navan rd,dublin comprised in folio 113016F of the register county dublin except that part thereof marked "HY7U"; (ii) property at cork rd,waterford,folio 18739F,county waterford; (iii) part of the lands of miltonsfields in the barony of nethercross,county of dublin,folio no 90295F; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0