TLLC HOLDINGS5 LIMITED

TLLC HOLDINGS5 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTLLC HOLDINGS5 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04592836
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TLLC HOLDINGS5 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Sleepy Hollow
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Oxfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BREWSTERDALE LIMITED18 nov 200218 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TLLC HOLDINGS5 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a Sleepy Hollow Aylesbury Road Thame Oxfordshire OX9 3AT el 08 feb 2019

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de a G Secretarial Limited como secretario el 11 ene 2016

    2 páginasTM02

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 dic 2014

    Estado de capital el 01 dic 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    Registro de la carga 045928360004

    148 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Grant Hearn como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Peter Darren Gowers como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2013

    Estado de capital el 05 nov 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Joanna Boydell como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Joanna Boydell como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jon Mortimore como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jon Mortimore como secretario

    2 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    legacy

    16 páginasMG01

    Cese del nombramiento de Guy Parsons como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TLLC HOLDINGS5 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    British164373820001
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer164373820001
    GOWERS, Peter Darren
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director157443090002
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant116809270002
    GARLAND, Michael Charles
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Secretario
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    UkAccountant174553070001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Secretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    BritishCompany Director93906210001
    SELLARS, Ian
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    Secretario
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    BritishDirector107731430001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    GARLAND, Michael Charles
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Director
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    United KingdomUkAccountant174553070001
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director88628480002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Director
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director93906210001
    PARKER, Carl Henry
    82 Alleyn Road
    Dulwich
    SE21 8AH London
    Director
    82 Alleyn Road
    Dulwich
    SE21 8AH London
    United KingdomBritishVenture Capitalist53480410003
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Director
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector83743120001
    SELLARS, Ian
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    Director
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    United KingdomBritishDirector107731430001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Director
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001

    ¿Tiene TLLC HOLDINGS5 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 29 nov 2013
    Entregado el 05 dic 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Aberdeen airport burnside drive off riverview drive aberdeen t/no ABN84416, aberdeen bucksburn A96 inverurie road bucksburn aberdeen t/no ABN79397, aberdeen central justice mill lane aberdeen t/no ABN107231 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    A supplemental debenture
    Creado el 25 oct 2012
    Entregado el 31 oct 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 oct 2012Registro de un cargo (MG01)
    Security accession deed
    Creado el 26 sept 2006
    Entregado el 04 oct 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 04 oct 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 18 dic 2002
    Entregado el 31 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Including (I) property at navan rd,dublin comprised in folio 113016F of the register county dublin except that part thereof marked "HY7U"; (ii) property at cork rd,waterford,folio 18739F,county waterford; (iii) part of the lands of miltonsfields in the barony of nethercross,county of dublin,folio no 90295F; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London,as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transacciones
    • 31 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0