ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED

ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04594316
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    • Actividades de los hogares de ancianos médicos (86102) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EASTWOOD CARE PARTNERSHIPS (NO.1.) LIMITED02 abr 200302 abr 2003
    BROOMCO (3065) LIMITED19 nov 200219 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 17 ago 2012

    1 páginasTM01

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    4 páginas1.1

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 dic 2011

    Estado de capital el 06 dic 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    26 páginasAA

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009

    25 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Smith como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kamma Foulkes como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Farmer como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304640001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector111188390002
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Director
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Director
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Director
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    BritishManaging Director110957990001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Director
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishDirector174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Director
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishDirector77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Director
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritishDirector147997950001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    ¿Tiene ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 14 nov 2003
    Entregado el 29 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 29 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 nov 2003
    Entregado el 04 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises situate at arkwright centre, irchester road, knuston, spinney, northampton, northants, NN9 7EY. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transacciones
    • 04 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 11 nov 2003
    Entregado el 25 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Abbeydale court nursing home, bistern avenue, walthamstow, london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transacciones
    • 25 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 11 nov 2003
    Entregado el 21 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit being the sum of £102,600 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "abeydale court nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 21 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 04 nov 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 04 nov 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 nov 2003
    Entregado el 13 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a colchester court nursing home, 120 colchester road, leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transacciones
    • 13 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 nov 2003
    Entregado el 13 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Orchard court nursing home, 3A orchard gardens, thurmaston, leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transacciones
    • 13 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 oct 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all right title and other interests of the company in l/h premises situate at holly lodge residential home 1 bocking hill haywood lane stocksbridge sheffield south yorkshire together with all buildings structures fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 14 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 30 oct 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 30 oct 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 oct 2003
    Entregado el 13 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a rufford court nursing home, 3/5 the cliff, cinderhill road, nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transacciones
    • 13 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises at holly house nursing home beechley harthill road allerton liverpool L18 3HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    In the l/h premises at holly house nursing home (barberry)12 ullet road aigburth liverpool L8 3SR. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises k/a tarry hill specialist residential home, 3,5 and 7 cale road, new mills, high peak, derbyshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0