TER 400 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTER 400 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04595020
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TER 400 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TER 400 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Victoria Works
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TER 400 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ICON PIECEAMBER LIMITED06 ene 200506 ene 2005
    ICON POLYMER GROUP LIMITED14 ene 200314 ene 2003
    PIECEAMBER LIMITED19 nov 200219 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TER 400 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TER 400 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 13 feb 2012

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Estado de capital el 10 feb 2012

    • Capital: GBP 0.156127
    6 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium reduced 06/02/2012
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Timothy Denzil Pryce el 24 ago 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Timothy Denzil Pryce el 15 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Timothy Denzil Pryce el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2008

    12 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de TER 400 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Secretario
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    BritishFinance Director112482850001
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Director
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    EnglandBritishFinance Director112482850001
    PRYCE, Timothy Denzil
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    Director
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector139882140005
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Secretario
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant104260670001
    JOHNSON, Joanne Elizabeth
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    Secretario
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    BritishSolicitor86411760001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Secretario
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    BritishFinancial Director44240520002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAILEY, Roger Piers Marden
    Cheriton
    Pikes Hill Avenue
    SO43 7AX Lyndhurst
    Hampshire
    Director
    Cheriton
    Pikes Hill Avenue
    SO43 7AX Lyndhurst
    Hampshire
    BritishSolicitor104169400001
    CALLAN, Maurice Simon
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director72172980001
    GOGERTY, Richard Howard
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    Director
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    EnglandBritishManaging Director83926860003
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Director
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant104260670001
    JOHNSON, Joanne Elizabeth
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    Director
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishSolicitor86411760001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Director
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector62509010002
    SIMM, Jonathan David
    Whitenap House
    Whitenap Lane
    SO51 5RR Romsey
    Hampshire
    Director
    Whitenap House
    Whitenap Lane
    SO51 5RR Romsey
    Hampshire
    BritishVenture Capitalist71817930002
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Director
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    BritishFinancial Director44240520002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene TER 400 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 24 dic 2004
    Entregado el 12 ene 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ene 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 24 dic 2004
    Entregado el 07 ene 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 07 ene 2005Registro de un cargo (395)
    Omnibus letter of set-off
    Creado el 12 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0