ACCESS PAYSUITE LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | ACCESS PAYSUITE LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04595169 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ACCESS PAYSUITE LTD?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra ACCESS PAYSUITE LTD?
| Dirección de la sede social | Armstrong Building Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACCESS PAYSUITE LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EAZY COLLECT SERVICES LIMITED | 20 nov 2002 | 20 nov 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ACCESS PAYSUITE LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ACCESS PAYSUITE LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 20 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 20 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACCESS PAYSUITE LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2024 | 21 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 116 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Andrea Maria Dunlop el 01 ago 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2023 | 20 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 112 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giulio Montemagno como director el 12 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 feb 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 abr 2023
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Old School School Lane Stratford St Mary Colchester CO7 6LZ England a Armstrong Building Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park Loughborough LE11 3QF el 21 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2022 | 15 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 120 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam John Witherow Brown como director el 26 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicolas Simon Williams como director el 26 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Comptes modifiés de filiale exemptée d'audit établis au 30 jun 2021 | 9 páginas | AAMD | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ACCESS PAYSUITE LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIS, Michael James | Director | Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough Armstrong Building England | England | British | 248206260001 | |||||
| BAYNE, Christopher Andrew Armstrong | Director | Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough Armstrong Building England | England | British | 35842030006 | |||||
| BINNS, Robert Hugh | Director | Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough Armstrong Building England | England | British | 206402020006 | |||||
| BROWN, Adam John Witherow | Director | Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough Armstrong Building England | England | British | 277451830001 | |||||
| DUNLOP, Andrea Maria | Director | Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough Armstrong Building England | England | British | 95625700006 | |||||
| MONTEMAGNO, Giulio | Director | Oakwood Drive Loughborough University Science & Enterprise Park LE11 3QF Loughborough Armstrong Building England | France | Italian | 320373480001 | |||||
| HESTER, Steven James | Secretario | Pinewood Drive GL51 0GH Cheltenham 49 Glos | British | 93671590004 | ||||||
| NAPIER, George Kenneth | Secretario | 51 Queens Road GL50 2LX Cheltenham Gloucestershire | British | 85860350001 | ||||||
| STALSBERG, Anthony Mitchell | Secretario | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | 173632090001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BLUNDELL, Stephen James | Director | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | England | British | 202454830001 | |||||
| BROWN, Adam John Witherow | Director | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | England | British | 75484830001 | |||||
| CARR, David | Director | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | England | British | 114423700001 | |||||
| HESTER, Steven James | Director | Tebbit Mews Winchcombe Street GL52 2NF Cheltenham 1 Gloucestershire England | England | British | 93671590004 | |||||
| NAPIER, Sally Rebecca | Director | 51 Queens Road GL50 2LX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 17712320001 | |||||
| STALSBERG, Alison Mary | Director | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | England | British | 74426140004 | |||||
| STALSBERG, Anthony Mitchell | Director | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | England | British | 68152730004 | |||||
| WHITTON, Nigel Anthony | Director | Tebbit Mews Winchcombe Street GL52 2NF Cheltenham 1 Gloucestershire England | England | British | 93814440001 | |||||
| WILLIAMS, Nicolas Simon | Director | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | England | British | 202191760002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ACCESS PAYSUITE LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Uk Ltd | 31 mar 2021 | School Lane Stratford St. Mary CO7 6LZ Colchester The Old School Essex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Armstrong Eazycollect Holdco Limited | 11 dic 2020 | More London Riverside SE1 2AP London 2 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Access Uk Ltd | 19 jun 2019 | School Lane Stratford St. Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mrs Alison Mary Stalsberg | 30 nov 2017 | Tebbit Mews Winchcombe Street GL52 2NF Cheltenham 1 Gloucestershire England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Anthony Mitchell Stalsberg | 20 nov 2016 | School Lane Stratford St Mary CO7 6LZ Colchester The Old School England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0