MMH P&C LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMMH P&C LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04600557
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MMH P&C LIMITED?

    • Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos (46720) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra MMH P&C LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o C/O GATELEY LLP
    One Eleven
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MMH P&C LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PARSON & CROSLAND LIMITED12 ene 200912 ene 2009
    P & C HOLDINGS LIMITED26 nov 200226 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MMH P&C LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MMH P&C LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MMH P&C LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 26 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 nov 2013

    Estado de capital el 26 nov 2013

    • Capital: GBP 4,103,133
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed parson & crosland LIMITED\certificate issued on 22/05/12
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    22 may 2012

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    Cese del nombramiento de David Lawson como director

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * Brightgate House Cobra Court 1 Brightgate Way Trafford Park Manchester M32 0TB* el 17 may 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de James Wilson como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2010

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Edward Bilcliffe como director

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2009

    20 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 abr 2010

    • Capital: GBP 4,103,133
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    legacy

    10 páginasMG01

    Nombramiento de Michael Scott Mcgill como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 26 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Edward Jocelyn Bilcliffe el 26 nov 2009

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    41 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Cambio de datos del secretario David William Murray Horne el 12 nov 2009

    3 páginasCH03

    Cambio de datos del director Graeme Hill el 17 nov 2009

    3 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de MMH P&C LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HORNE, David William Murray
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    Secretario
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    British41593900004
    HILL, Graeme Everitt
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    Director
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    EnglandBritishDirector144984260001
    MCGILL, Michael Scott
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    Director
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    ScotlandBritishFinance Director99070570001
    STAYMAN, Malcolm Sanderson
    35 Fountains Avenue
    Ingleby Barwick
    TS17 0TX Stockton On Tees
    Cleveland
    Secretario
    35 Fountains Avenue
    Ingleby Barwick
    TS17 0TX Stockton On Tees
    Cleveland
    British45439060001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BILCLIFFE, Edward Jocelyn
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    Director
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    EnglandBritishCompany Director75680950001
    CRANE, Ian Alan
    16 St Lucia Lane
    TS14 8BY Guisborough
    Cleveland
    Director
    16 St Lucia Lane
    TS14 8BY Guisborough
    Cleveland
    United KingdomBritishDirector12665310001
    CROSLAND, Diana Elizabeth
    Maam
    Inveraray
    PA32 8X1 Argyll
    Scotland
    Director
    Maam
    Inveraray
    PA32 8X1 Argyll
    Scotland
    BritishCo Director45816710001
    FOTHERINGHAM, George Andrew, Mr.
    7 Holyrood Avenue
    DL3 8AZ Darlington
    County Durham
    Director
    7 Holyrood Avenue
    DL3 8AZ Darlington
    County Durham
    EnglandBritishDirector63986340001
    LAWSON, David Barrie
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    Director
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    EnglandBritishDirector122575270001
    LEARMOND, Nigel James Alexander
    52 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Director
    52 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    EnglandBritishDirector1627050001
    LEARMOND, Nigel James Alexander
    52 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Director
    52 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    EnglandBritishDirector1627050001
    WILSON, James Donald Gilmour
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    Director
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    ScotlandBritishAccountant69298770001

    ¿Tiene MMH P&C LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 20 abr 2010
    Entregado el 28 abr 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    Legal charge
    Creado el 08 abr 2009
    Entregado el 17 abr 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a newport works forty foot road middlesborough t/no's CE140455, CE165263, CE165264 and TES34383.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2009Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 04 dic 2008
    Entregado el 17 dic 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 dic 2008Registro de un cargo (395)
    Charge over shares
    Creado el 21 ene 2008
    Entregado el 01 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge all right title and interest in and to the shares including divided and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 01 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 21 ene 2008
    Entregado el 01 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge all right title and interest in and to the shares including dividend and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 01 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 20 dic 2002
    Entregado el 06 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0