JNP VENTURES 2 LIMITED

JNP VENTURES 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJNP VENTURES 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04602538
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JNP VENTURES 2 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JARVISHELF 39 LIMITED27 nov 200227 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Latham Nelson el 25 nov 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Paul Birch el 16 ene 2020

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Andrew Lee Milner como director el 12 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    11 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Sherard Secretariat Services Limited el 02 sept 2019

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB el 02 sept 2019

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Amey Tube Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept 2019

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Amey Tube Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr Paul Birch como director el 12 may 2017

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    10 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Lee Milner como director el 19 feb 2016

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Director
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritishCorporate Services Director76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Director
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector36191090004
    HUI, Carol
    GU8
    Secretario
    GU8
    British72371980001
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Frogmore Hall
    Frogmore Park
    SG14 3RU Watton On Stone
    Hertfordshire
    Secretario corporativo
    Frogmore Hall
    Frogmore Park
    SG14 3RU Watton On Stone
    Hertfordshire
    70053320011
    CARLISLE, Celia Diana
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    Director
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    United KingdomBritishProject Financier63756390001
    COPELAND, Ian Christopher
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    Director
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    UsaCompany Director80111500002
    CORBIN, Brian James
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    Director
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    BritishBusiness Executive87942120001
    COTTRELL, Keith
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritishInvestment Manager88691090005
    DOVE, Robert Wallace
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    Director
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    BritishManaging Director80507460001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector61515760002
    FENTON, Christopher Victor
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director114610580002
    GARTSHORE, Andrew Robert
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    Director
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    New ZealanderBusiness Executive87942040001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Director
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector57954340003
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    SpanishGroup Finance Director93348510004
    MALARKEY, John Murray
    The Beeches
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    Director
    The Beeches
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    AmericanProject Financier85773840001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Director
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishChartered Secretary37404250003
    MAWDSLEY, Alan Dean
    6 Nepean Street
    SW15 5DW London
    Director
    6 Nepean Street
    SW15 5DW London
    Us CitizenDirector47237210001
    MELLOR, Margaret Louise
    51 Forest Side
    Chingford
    E4 6BA London
    Director
    51 Forest Side
    Chingford
    E4 6BA London
    United KingdomBritishChartered Secretary80354780001
    MILNER, Andrew Lee
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Director
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Civil Engineer133714170002
    MILNER, Andrew Lee
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritishChartered Civil Engineer133714170002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector87961010001
    REES, Paul Meredith
    32 Oxford Road
    Littlemore
    OX4 4PE Oxford
    Director
    32 Oxford Road
    Littlemore
    OX4 4PE Oxford
    United KingdomBritishBusiness Executive96767270001
    ROEHL, Jeffrey Stewart
    2247 Clay Street
    San Francisco
    Ca 94115
    Usa
    Director
    2247 Clay Street
    San Francisco
    Ca 94115
    Usa
    AmericanCompany Director99299140001
    SUTHERLAND, Douglas Iain
    Claro House Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Claro House Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCivil Servant257902560001
    WICKERSON, Richard John
    80 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PG London
    Director
    80 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PG London
    United KingdomBritishCompany Director54758760002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    06 abr 2016
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4602869
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene JNP VENTURES 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Account charge
    Creado el 23 dic 2002
    Entregado el 08 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Uic International Ii Limited
    Transacciones
    • 08 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Account charge
    Creado el 23 dic 2002
    Entregado el 07 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The account held by the company with the deposit bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Uic International Ii Limited (The "Secured Party")
    Transacciones
    • 07 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second ranking account charge
    Creado el 23 dic 2002
    Entregado el 24 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations due or to become due from the company to the chargee (secured party) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Credit balance from time to time in the relevant accounts (and any renewal or redesignation thereof) maintained with the deposit bank by the company and all rights,benefits and proceeds in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Jarvis PLC (The Secured Party)
    Transacciones
    • 24 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First ranking account charge
    Creado el 23 dic 2002
    Entregado el 24 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations due or to become due from the company to the chargee (secured party) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Credit balance from time to time in the relevant accounts (and any renewal or redesignation thereof) maintained with the deposit bank by the company and all rights,benefits and proceeds in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Jarvis PLC (The Secured Party)
    Transacciones
    • 24 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An account charge
    Creado el 21 dic 2002
    Entregado el 23 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge and with full title guarantee the deposit being the credit balance from time to time in the JNPV2 (l/c 13) collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Trustee for and on Behalf of the Securedparties
    Transacciones
    • 23 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deposit agreement and account charge
    Creado el 21 dic 2002
    Entregado el 23 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge and with full title guarantee the deposit being the deposit balance from time to time of the JNPV2 collection account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Trustee for and on Behalf of the Securedparties
    Transacciones
    • 23 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An account charge
    Creado el 21 dic 2002
    Entregado el 23 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge and with full title guarantee the deposit being the credit balance from time to time in the JNPV2 (l/c 11 and 12) collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Trustee for and on Behalf of the Securedparties
    Transacciones
    • 23 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0